GRADUS FABRICS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GRADUS FABRICS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04298011 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GRADUS FABRICS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GRADUS FABRICS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 3rd Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GRADUS FABRICS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EVER 1630 LIMITED | 03 ott 2001 | 03 ott 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GRADUS FABRICS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per GRADUS FABRICS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Gradus Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 16 ago 2017 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||
Cessazione della carica di Craig William Rice come amministratore in data 30 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Craig William Rice come segretario in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di James Jack Collier come segretario in data 31 mar 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Tierney come amministratore in data 31 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Phillippe Dominique Marie Puech come amministratore in data 30 ott 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Edouard Jean Michel Phelippeau come amministratore in data 30 ott 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Pierre Dominique Denis Convers come amministratore in data 30 ott 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Pierre Marc Lienhard come amministratore in data 30 ott 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Craig William Rice il 12 dic 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF a 3Rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT in data 12 set 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di GRADUS FABRICS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLIER, James Jack | Segretario | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | 228286880001 | |||||||
| CONVERS, Pierre Dominique Denis | Amministratore | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire | France | French | 127290570001 | |||||
| LIENHARD, Pierre Marc | Amministratore | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire | France | French | 202917150001 | |||||
| PHELIPPEAU, Edouard Jean Michel | Amministratore | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire | France | French | 202918450001 | |||||
| PUECH, Philippe Dominique Marie | Amministratore | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire | France | French | 202919330001 | |||||
| WATT, Stephen Andrew | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | England | British | 71166390005 | |||||
| RICE, Craig William | Segretario | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | British | 29450670004 | ||||||
| WITZENFELD, Jeffrey Phillip | Segretario | 123 Monkhams Avenue IG8 0ER Woodford Green Essex | British | 14978070002 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario nominato | Sun Alliance House 35 Mosley Street NE1 1AN Newcastle Upon Tyne | 900018440001 | |||||||
| GREEN, Mitchell Howard | Amministratore | Pennington 88 High Road IG7 6PJ Chigwell Essex | British | 19510590001 | ||||||
| RICE, Craig William | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | Uk | British | 29450670005 | |||||
| STOCKS, Peter Leslie | Amministratore | 21 Norheads Lane TN16 3XS Biggin Hill Kent | British | 32498870001 | ||||||
| TIERNEY, David | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | England | British | 40155770002 | |||||
| WHITELAW, William Leslie | Amministratore | 48 Fence Avenue SK10 1LT Macclesfield Cheshire | British | 42264190001 | ||||||
| WITZENFELD, Jeffrey Phillip | Amministratore | 123 Monkhams Avenue IG8 0ER Woodford Green Essex | England | British | 14978070002 | |||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | Sun Alliance House 35 Mosley Street NE1 1AN Newcastle Upon Tyne | 900018430001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GRADUS FABRICS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradus Limited | 06 apr 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GRADUS FABRICS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 03 ott 2016 | 14 ago 2017 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
GRADUS FABRICS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 28 mar 2007 Consegnato il 05 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 feb 2007 Consegnato il 02 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 21 december 2001 | Creato il 08 dic 2004 Consegnato il 16 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charging company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 dic 2002 Consegnato il 24 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0