EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED

EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04299729
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED?

    • Gestione di fondi (66300) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHELFCO (NO.2587) LIMITED05 ott 200105 ott 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 nov 2020

    10 pagineLIQ03

    Dettagli del segretario cambiati per Cromwell Corporate Secretarial Limited il 07 set 2020

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 25 nov 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 nov 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Mr John Reginald Le Prevost come persona con controllo significativo il 24 giu 2019

    2 paginePSC04

    Cessazione della carica di Claire Treacy come amministratore in data 15 feb 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Ciara Fitzgibbon come amministratore in data 15 feb 2019

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Valad Fund Management Holdings (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH04

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ott 2015

    Stato del capitale al 15 ott 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Fraser James Kennedy come amministratore in data 14 ago 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David John Kirkby come amministratore in data 31 lug 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Segretario
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520004
    FITZGIBBON, Ciara
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandIrish255388410001
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5307786
    102622300003
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Segretario
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    ZAJAC, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320002
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    BEARMAN, Christian James Alexander
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish227996930001
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish72399980002
    FENNELL, Darren James
    Wiggins Cottage
    Goosey
    SN7 8PA Faringdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Wiggins Cottage
    Goosey
    SN7 8PA Faringdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish64532590001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    KIRKBY, David John
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomAustralian110761830001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    OLIVER, Paul Francis
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomBritish14735150002
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Amministratore
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TREACY, Claire
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United KingdomIrish189529610001
    TUTTON, Jeremy John
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    Amministratore
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    British100816670001
    MIKJON LIMITED
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    Amministratore
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    72341560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Michael James Wall
    Havilland Street
    St. Peter Port
    GY1 2QE Guernsey
    C/O Anson Operations (Uk) Limited
    Channel Islands
    06 apr 2016
    Havilland Street
    St. Peter Port
    GY1 2QE Guernsey
    C/O Anson Operations (Uk) Limited
    Channel Islands
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Channel Islands
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Cromwell Investment Holdings Uk Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06 apr 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione4311414
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr John Reginald Le Prevost
    Anson House
    Havilland Street
    GY1 2QE St Peter Port
    C/O Anson Operations (Uk) Limited
    Guernsey
    Channel Islands
    06 apr 2016
    Anson House
    Havilland Street
    GY1 2QE St Peter Port
    C/O Anson Operations (Uk) Limited
    Guernsey
    Channel Islands
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Guernsey
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security executed on 27 may
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 15 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Queensberry house queensberry street dumfries scotland t/no DMF5554.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to the security trustee for the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole right title interest and benefit in and to the rental income and all rental deposits and guarantees held pursuant or supplemental to the leases see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mag 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 22 lug 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security executed on 27 may 2010
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1 drum mains park cumbernauld glasgow scotland t/no DMB53236.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security executed on 27 may 2010
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Gretna hall hotel gretna green dumfries scotland t/no DMF16592.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security executed on 27 may 2010
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    87 high street dumfries scotland t/no DMF12495.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security executed on 27 may 2010
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    144/146 high street ayr scotland t/no AYR51122.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security executed on 27 may 2010
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    12-14 albyn terrace aberdeen scotland t/no ABN56771.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security executed on 27 may 2010
    Creato il 01 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    13 albyn terrace aberdeen scotland t/no ABN56770.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge over disposal proceeds account
    Creato il 27 mag 2010
    Consegnato il 10 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to the security trustee for the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All or any part of the amounts credited to or otherwise forming part of the account or the deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 10 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge over general account
    Creato il 27 mag 2010
    Consegnato il 10 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting as general partner of the osprey limited partnership and each group company to the security trustee for the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All or any part of the amounts credited to or otherwise forming part of the account or the deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 10 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 mag 2010
    Consegnato il 11 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company in its capacity as general partner of the osprey limited partnership and each group company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    127-129 high street t/no SGL50019. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 11 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 27 mag 2010
    Consegnato il 04 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the borrower and each other group company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery (for details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 04 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 ago 2009
    Consegnato il 03 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a unit 1, arrow valley industrial estate, claybrook drive, redditch t/no WR96391 and f/h land and buildings k/a unit c langham park, trent lane, castle donnington, derbyshire t/no LT401889 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Bos)
    Transazioni
    • 03 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 22 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at the back of roman way hotel watling street hatherton t/no SF415066 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings k/a elmfield business park garforth leeds t/no WYK854018. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings k/a unit a and unit b normanton t/no WYK782443. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 nov 2007
    Consegnato il 07 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a vinylex building olympus park quedgeley gloucester t/no GR197507. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 07 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 09 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings k/a elmfield business park garforth leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 1 groundwell industrial estate stephenson road swindon t/no WT232422. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and Each of Thelenders (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 2006
    Consegnato il 23 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company in its capacity as general partner of the osprey limited partnership to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property known as the chequers hotel oxford street newbury berkshire t/n BK246526,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and Each of Thelenders (Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 2006
    Consegnato il 23 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company in its capacity as general partner of the osprey limited partnership to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property known as the roman way hotel watling street hatherton cannock staffordshire t/n SF250859 and all the f/h property being land adjoining pleasant acres watling street cannock staffordshire t/n SF501130,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and Each of Thelenders (Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 3 july 2006 and
    Creato il 21 giu 2006
    Consegnato il 07 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming gretna hall hotel, gretna green, dumfriesshire t/no DMF16592.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and Each of Thelenders (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16 august 2005 and
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 20 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the owner to the lenders (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 drum mains park orchardton woods cumbernauld t/no DMB53236.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and Each of the Lenders (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on benefical interest
    Creato il 02 giu 2005
    Consegnato il 03 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 24 whitton street northwich t/no CH153669 and l/h proeprty k/a land and buildings on the east and west side of witton walk northwich t/no CH357086AND the proceeds of sale thereof and the charged assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 28 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H queens house queen street exeter t/no DN71889.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    EQUITY PARTNERSHIPS (OSPREY) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 nov 2019Inizio della liquidazione
    14 mar 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0