AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED

AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04301069
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Aon Centre The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LORICA CONSULTING LIMITED15 lug 200515 lug 2005
    HEALTH FOR INDUSTRY LIMITED25 gen 200225 gen 2002
    CONTACTBASE LIMITED09 ott 200109 ott 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 set 2016

    LRESSP

    Cessazione della carica di David Charles Battle come amministratore in data 21 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christine Marie Williams come amministratore in data 19 set 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alistair Patrick Boyd come amministratore in data 19 set 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Paul Arthur Hogwood come amministratore in data 23 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tobin Mathew Murphy-Coles come amministratore in data 01 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Neville Herbert come amministratore in data 19 lug 2016

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Dec nom cap 20/11/2015
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 nov 2015

    • Capitale: GBP 0.01
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 09 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2015

    Stato del capitale al 21 ott 2015

    • Capitale: GBP 250,100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Charles Battle il 13 lug 2015

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 8 Devonshire Square London EC2M 4PL England a 10 Devonshire Square London EC2M 4YP

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 8 Devonshire Square London EC2M 4PL

    1 pagineAD03

    Dettagli del segretario cambiati per Cosec 2000 Limited il 13 lug 2015

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Christine Marie Williams il 13 lug 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per James Neville Herbert il 13 lug 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COSEC 2000 LIMITED
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre, The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Segretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre, The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03127178
    152185840001
    BOYD, Alistair Patrick
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    Amministratore
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United KingdomBritish214544820001
    HOGWOOD, Paul Arthur
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    Amministratore
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United KingdomBritish7453920005
    BUHAGIAR, Bryan
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    Segretario nominato
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    British900011210001
    GODSELL, Jeanette Louise
    30 St Michaels Road
    GU47 8HE Sandhurst
    Berkshire
    Segretario
    30 St Michaels Road
    GU47 8HE Sandhurst
    Berkshire
    British75623730001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Segretario
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Segretario
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Segretario
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    PEAKE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    Segretario
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01887672
    55731680011
    BATTLE, David Charles
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish111477590002
    BEAUMONT, Peter Stuart
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    British78770280001
    BIBBY, John
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    British27995540003
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40471660002
    BRADLEY, Stephen Michael
    Little London Cottage
    61-62 High Street
    BA12 0EB Heytesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Little London Cottage
    61-62 High Street
    BA12 0EB Heytesbury
    Wiltshire
    EnglandBritish75623610001
    BUHAGIAR, Susan
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    United KingdomBritish900011200001
    CARTER, Patrick Robert
    Rue De Peuplier 7-9
    FOREIGN 1000 Brussels
    Belgium
    Amministratore
    Rue De Peuplier 7-9
    FOREIGN 1000 Brussels
    Belgium
    British81585030001
    CLARIDGE-WARE, Christopher Maurice
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    The Grange
    Berkshire
    Amministratore
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    The Grange
    Berkshire
    United KingdomBritish5828350004
    CONNELL, Alistair James
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish154274870002
    COOMBER, Karen Maria
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    Amministratore
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    EnglandBritish100159270003
    EDMANDS, David James Rosewall
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    Amministratore
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    United KingdomBritish118042260001
    HERBERT, James Neville
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish164559940002
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Amministratore
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    British79523100001
    JACKSON, John David, Mr.
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Amministratore
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    United KingdomBritish166242060001
    JAMES, Philip William Henry
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    Amministratore
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    British33901640005
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Amministratore
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    KING, Michael Henry
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    Amministratore
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    British14395670002
    KLAIRE, Clare Elizabeth
    1 Chalk Dell Cottages
    Chawton Park Road, Chawton
    GU34 1SW Alton
    Hampshire
    Amministratore
    1 Chalk Dell Cottages
    Chawton Park Road, Chawton
    GU34 1SW Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish75623670001
    MARLEY, Nicholas James
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    Amministratore
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    United KingdomBritish113304050001
    MARLEY, Nicholas James
    2 Nursery Road
    Merton
    SW19 3BT London
    Amministratore
    2 Nursery Road
    Merton
    SW19 3BT London
    British81585110001
    MORLEY, James
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom13374700001
    MORLEY HAM, Stephen Richard
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    Amministratore
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    British80334700004
    MURPHY-COLES, Tobin Mathew
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161141640001
    MURRAY, Alastair Neil
    B303, Gilbert Scott Building
    Scott Avenue
    SW15 3ST Putney
    Amministratore
    B303, Gilbert Scott Building
    Scott Avenue
    SW15 3ST Putney
    United KingdomBritish124855970001
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    Amministratore
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    Amministratore
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A composite debenture
    Creato il 13 dic 2012
    Consegnato il 22 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 22 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A composite debenture
    Creato il 14 nov 2008
    Consegnato il 18 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties
    Transazioni
    • 18 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2008
    • 14 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 15 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse,London Branch
    Transazioni
    • 15 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 feb 2006
    Consegnato il 02 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 lug 2005
    Consegnato il 09 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,862.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £15,862.50.
    Persone aventi diritto
    • Amprop Limited
    Transazioni
    • 09 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 mag 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all the goodwill and uncalled capital the securities the insurances the rents the fixed plant and equipment by way of first floating charge all those assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mr Rar Francis, Mr Ajm Hutchins, Mr Po Jones
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 01 mag 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the charged property to the chargee and upon an enforcement eventall dividends distributions, distributions in specie interest and other monies payable in respect of the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mr Rar Francis, Mr Ajm Hutchins, Mr Po Jones
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over dividends and shares
    Creato il 30 ott 2003
    Consegnato il 01 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The charged shares , any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares and all dividends, distributions and other monies payable in respect of charged shares.
    Persone aventi diritto
    • Paul Brantingham
    Transazioni
    • 01 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over dividends and shares
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 02 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of a fixed charge the shares and any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Brantingham and Mark Brantingham
    Transazioni
    • 02 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creato il 08 ott 2002
    Consegnato il 16 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £42,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Its interest in the deposit account (as defined in the deed) and all money withdrawn from the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Intel Corporation (UK) Limited
    Transazioni
    • 16 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 set 2016Inizio della liquidazione
    03 apr 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0