CURO GROUP (ALBION) LIMITED
Panoramica
Nome della società | CURO GROUP (ALBION) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Convertita/Chiusa |
Forma giuridica | Convertita o chiusa |
Numero di società | 04302179 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
- Attività di altre organizzazioni di categoria n.c.a. (94990) / Altre attività di servizi
Dove si trova CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SOMER HOUSING GROUP LIMITED | 10 ott 2001 | 10 ott 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2019 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2019 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varie Combined form b/z convert to rs | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2018 | 54 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Victor Da Cunha come segretario in data 20 apr 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Ms Katherine Gullon come segretario in data 20 apr 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Emily Wilson come segretario in data 20 apr 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2017 | 59 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Emily Wilson come segretario in data 20 nov 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philippa Armstrong come segretario in data 21 nov 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Nathan Stillwell il 08 set 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon David Gibbs come amministratore in data 20 feb 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dermot Gerard Courtier come amministratore in data 20 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 23 pagine | MA | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2016 | 68 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher John Wilson come amministratore in data 21 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Victor Manuel Silva Da Cunha come amministratore in data 21 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Ashmore come amministratore in data 17 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | pagine | ANNOTATION | ||||||||||
Nomina di Ms Elaine Barnes come amministratore in data 04 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Rick De Blaby come amministratore in data 17 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brian Tapp come amministratore in data 17 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin William Nurse come amministratore in data 17 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GULLON, Katherine | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 245679730001 | |||||||
ASHMORE, David | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | Director | 217179970001 | ||||
BARNES, Elaine | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | Executive Director | 103202570001 | ||||
DA CUNHA, Victor Manuel Silva | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | Group Chief Executive | 104048750002 | ||||
DE BLABY, Rick | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | Chief Executive | 216828360001 | ||||
GIBBS, Simon David | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | Finance Director | 223221690001 | ||||
POTTER, Elizabeth Anne | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | Self Employed | 172516960001 | ||||
STILLWELL, Richard Nathan | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | Company Director | 80064790001 | ||||
WILSON, Christopher John | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | Director | 219228600001 | ||||
ARMSTRONG, Philippa | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 201723040001 | |||||||
ARMSTRONG, Philippa | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | British | Head Of Governance | 108400480001 | |||||
BROOKE, Rosalind | Segretario | 4 Southview Timsbury BA2 0LZ Bath | British | Interim Group Company Secretar | 16839520002 | |||||
CLARKE, David | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 188800610001 | |||||||
CLARKE, David | Segretario | Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings River Place | British | 151390140001 | ||||||
DA CUNHA, Victor | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 194531300001 | |||||||
DA CUNHA, Victor | Segretario | Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings River Place Uk | British | 159387250001 | ||||||
HALL, Diane Patricia | Segretario | 33 Orchard Way North Bradley BA14 0SU Trowbridge Wiltshire | English | 38198930003 | ||||||
HALL, Diane Patricia | Segretario | 33 Orchard Way North Bradley BA14 0SU Trowbridge Wiltshire | English | 38198930003 | ||||||
HASTINGS, Richard | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 188797000001 | |||||||
HILL, Alexandra Abigail | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 194531090001 | |||||||
INFANTE, Brenda | Segretario | River Place Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings Uk | British | 177383710001 | ||||||
MOXHAM, Maria | Segretario | 2 Pinetum Close SN10 5EW Devizes Wiltshire | British | 100167950001 | ||||||
SMITHERS, Tonia Lorraine | Segretario | Fosseway Midsomer Norton BA3 4AU Radstock 1 Little Orchard Somerset | British | 128054140001 | ||||||
WATSON, Steve | Segretario | Masters Farm Well Road BA3 4SD Emborough Somerset | British | Group Chief Executive | 124975860001 | |||||
WILSON, Emily | Segretario | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 240507780001 | |||||||
APPLEYARD, Robin Alan, Cllr | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | Politician | 157193430001 | ||||
BADER, David John | Amministratore | Groves Road NP20 3SP Newport 20 Gwent | United Kingdom | British | Retired Civil Servant | 84821210001 | ||||
BATTERSBY, Tom | Amministratore | Grosvenor Villas BA1 6QL Bath 10 Avon | United Kingdom | British | Head Of Ict | 133460880002 | ||||
BLIGH, Juliet Elizabeth | Amministratore | 14 Clyde Road Redland BS6 6RP Bristol Avon | England | British | Research Consultant | 108807800001 | ||||
BLIGH, Juliet Elizabeth | Amministratore | 14 Clyde Road Redland BS6 6RP Bristol Avon | England | British | Research Consultant | 108807800001 | ||||
BRISCOE, Graham Owen | Amministratore | Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings River Place | England | British | Housing Association Ned And College Governor | 17350840001 | ||||
CONNOR, Margaret Jacqueline | Amministratore | Ashcroft Avenue Keynsham BS31 2EX Bristol 21 Avon | Uk | British | Carer | 80039210002 | ||||
COURTIER, Dermot Gerard | Amministratore | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | Hr Director Pensions Executive | 134345640001 | ||||
DAVEY, Joanna Mary | Amministratore | 2 Glenview Titlands Lane Wookey Hole BA5 1BD Wells Somerset | British | Consultant | 59582530001 | |||||
DAVEY, Joanna Mary | Amministratore | 2 Glenview Titlands Lane Wookey Hole BA5 1BD Wells Somerset | British | Consultant Trainer | 59582530001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
10 ott 2016 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
CURO GROUP (ALBION) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Shg debenture | Creato il 12 lug 2004 Consegnato il 21 lug 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee, any nominee, delegate or agent thereof or any receiver, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed charge all rights under or in respect of the documents, all rights, title and interest in and to the documents, by way of first floating charge the undertaking and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0