PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED

PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04304555
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Shard Duff & Phelps Ltd., Level 14
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IBIS (690) LIMITED15 ott 200115 ott 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 129-137 Marylebone Road London NW1 5QD a The Shard Duff & Phelps Ltd., Level 14 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 15 nov 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Tracey Lee Pye come amministratore in data 22 ott 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Declan Mckelvey come amministratore in data 17 ott 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2017

    2 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 10/07/2018
    RES13

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Accounts approved/instructions to file accounts 10/07/2018
    RES13

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione di Carmen Properties Ltd come persona con controllo significativo il 24 apr 2018

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2016

    2 pagineAA

    Nomina di Ms Tracey Pye come amministratore in data 20 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Darren Lee Topp come amministratore in data 20 feb 2017

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2016 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Emma Ann Reid come segretario in data 03 giu 2016

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2015

    2 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    38 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    39 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Darren Lee Topp come amministratore in data 06 mag 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Dominic Leonard Mark Chandler come amministratore in data 06 mag 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCKELVEY, Declan
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129 - 137
    England
    Amministratore
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129 - 137
    England
    EnglandBritishAccountant252242430001
    CASH, Daphne Valerie
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    Segretario
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    British59646330004
    ELLIOTT, Kevin Paul
    Oakham House
    10b Leicester Road
    LE65 1DE Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Segretario
    Oakham House
    10b Leicester Road
    LE65 1DE Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishPurchasing Manager79601130001
    HAZELL, Dawn Elaine
    c/o Bellrock Property & Facilities Management
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    Segretario
    c/o Bellrock Property & Facilities Management
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    British112851320001
    OGG, Gary Mark
    Woodside House
    166 Knighton Church Road
    LE2 3JL Leicester
    Segretario
    Woodside House
    166 Knighton Church Road
    LE2 3JL Leicester
    United Kingdom98350390001
    REID, Emma Ann
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    Segretario
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    199592160001
    DECHERT SECRETARIES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Segretario
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    78403190002
    ALLKINS, Ian Mark
    35 Brentham Way
    W5 1BE London
    Amministratore
    35 Brentham Way
    W5 1BE London
    EnglandBritishAccountant69334980003
    CHANDLER, Dominic Leonard Mark
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    Amministratore
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    United KingdomBritishDirector189507470001
    CHAPPELL, Dominic Joseph Andrew
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    Amministratore
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    United KingdomBritishDirector193569160001
    COACKLEY, Paul
    Garden House
    1 Tudor Road
    BR3 6QR Beckenham
    Kent
    Amministratore
    Garden House
    1 Tudor Road
    BR3 6QR Beckenham
    Kent
    BritishAccountant69335100001
    ELLIOTT, Kevin Paul
    Oakham House
    10b Leicester Road
    LE65 1DE Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    Oakham House
    10b Leicester Road
    LE65 1DE Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    United KingdomBritishPurchasing Manager79601130001
    HENNINGSON, Lennart David
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    Amministratore
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    England
    SwedenSwedishDirector195757530001
    PYE, Tracey Lee
    18 Westway
    Holmes Chapel
    CW4 7DH Cheshire
    Storm Advisory Limited
    England
    Amministratore
    18 Westway
    Holmes Chapel
    CW4 7DH Cheshire
    Storm Advisory Limited
    England
    United KingdomBritishAccountant200582850001
    READMAN, John Paul
    c/o Bellrock Property & Facilities Management
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    Amministratore
    c/o Bellrock Property & Facilities Management
    Sunningdale Road
    LE3 1UR Leicester
    Enterprise House
    England
    United KingdomBritishCompany Director119991730003
    TOPP, Darren Lee
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    Amministratore
    Marylebone Road
    NW1 5QD London
    129-137
    United KingdomBritishChief Executive208060210001
    WALL, Mark Stuart
    Stonepits Farm, Pickards Lane
    Main Street, Wycombe
    LE14 4QH Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Stonepits Farm, Pickards Lane
    Main Street, Wycombe
    LE14 4QH Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritishBuilding Surveyor69373460001
    DECHERT NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Amministratore
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    73625410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Carmen Properties Ltd
    Les Cour Des Casernes
    JE1 3NH St Hellier
    Nautilus House
    Jersey
    06 apr 2016
    Les Cour Des Casernes
    JE1 3NH St Hellier
    Nautilus House
    Jersey
    Forma giuridicaRegistered Private Company
    Paese di registrazioneJersey
    Autorità legaleJersey
    Luogo di registrazioneJfsc Companies Registry
    Numero di registrazione81511
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PROPCO (HANLEY NO.1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 apr 2015
    Consegnato il 21 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Land at 9 11 13 and 15 parliament row hanley t/no. SF291303. Land and buildings at westside of goodson street hanley t/no.SF80902 for further details of property charged please refer to instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 05 gen 2007
    Consegnato il 18 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 2007
    Consegnato il 19 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings k/a 9, 11, 13 and 15 parliament row and land and buildings on the west side of goodson street hanley t/no's SF291303 and SF80902. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 20 dic 2001
    Consegnato il 09 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage l/h property k/a store a broadway shopping centre bexleyheath t/n-SGL585951. F/h 9, 11, 13 and 15 parliament row hanley SF291303. F/h land and buildings on the west side of goodson street hanley t/n-SF80902 (see form 395 for further property details). By way of first fixed charge all plant and machinery, goodwill & uncalled capital; by way of first floating charge all its assets not otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage or charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch as Agent and Trustee for Thetransaction Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 09 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 20 dic 2001
    Consegnato il 04 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h store a broadway shopping centre bexleyheath t/n-SGL58951. F/h 9, 11, 13 and 15 parliament row hanley t/n-SF291303. F/h land and buildings on the west side of goodson street hanley t/n-SF80902 (see form 395 for further details of properties charged). By way of fixed charge all plant and machinery goodwill uncalled capital. By way of loating charge all its assets not otherwise effectively mortgaged or charged or assigned by way of fixed mortgage or charge or assignment.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cristina Stuart Green
    Transazioni
    • 04 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0