WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED

WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04306999
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Peterborough Services Great North Road
    Haddon
    PE7 3UQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAMSARD 2402 LIMITED18 ott 200118 ott 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al06 ott 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    9 pagineMG04

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Craig Stuart Beevers come amministratore in data 13 mag 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ott 2011

    Stato del capitale al 05 ott 2011

    • Capitale: GBP 2,708,001
    SH01

    Nomina di Mr Trishul Thakore come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 06 ott 2010

    19 pagineAA

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2010 al 06 ott 2010

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Craig Stuart Beevers come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Harold Denis Mccarney come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Harold Denis Mccarney come segretario

    3 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Castle Hill Lincoln Lincolnshire LN1 3AA in data 05 nov 2010

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Stephen Spouge come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon Pullan come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon Pullan come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Robert Wade come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Spouge come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Goodwill come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCARNEY, Harold Denis
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    Segretario
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    British155463470001
    MCCARNEY, Harold Denis
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    Amministratore
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    United KingdomIrishDirector90469430002
    THAKORE, Trishul
    Piccadily
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    Amministratore
    Piccadily
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    United KingdomBritishDirector159206370001
    PULLAN, Gordon Waite
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    Segretario
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    BritishChartered Accountant72016900002
    HAMMONDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Segretario
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580008
    BEEVERS, Craig Stuart
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    Amministratore
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    EnglandBritishDirector103311310001
    GOODWILL, Geoffrey Mortimer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor100020003
    LONG, Andrew Edward
    The Old Rectory
    Rectory Road, Coleby
    LN5 0AJ Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Rectory Road, Coleby
    LN5 0AJ Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor2537680002
    PULLAN, Gordon Waite
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    Amministratore
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    EnglandBritishChartered Accountant72016900002
    SPOUGE, Stephen William
    1 Castle Hill
    Lincoln
    LN1 3AA Lincolnshire
    Amministratore
    1 Castle Hill
    Lincoln
    LN1 3AA Lincolnshire
    EnglandBritishDirector2537020001
    SPOUGE, Stephen William
    The Grange Barlings
    Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Grange Barlings
    Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritishProperty Developer2537020001
    SPOUGE, Timothy James
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishOperations Director46349280001
    WADE, Robert Alexander Mercer
    Vergers House
    1 The Old Palace Palace Road
    HG4 3HF Ripon
    Amministratore
    Vergers House
    1 The Old Palace Palace Road
    HG4 3HF Ripon
    United KingdomBritishConsultant14261170002
    HAMMONDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Amministratore
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    73774730003

    WINCHESTER MSA FORECOURTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 ott 2010
    Consegnato il 16 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 16 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 apr 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 24 giu 2008
    Consegnato il 01 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 17 ott 2007
    Consegnato il 20 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights,title and interest in and to the account balances and by way of first fixed charge and by way of first floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ago 2007
    Consegnato il 23 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H fuel filling station facility at junctions 8 and 9, M3 shroner wood winchester hampshire t/no HP552876 all ental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 23 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 28 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As "Security Trustee")
    Transazioni
    • 28 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 22 nov 2004
    Consegnato il 07 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee charges to the creditor as security for the payment or discharge of the secured obligations by way of floating charge all the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 07 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and legal charge
    Creato il 22 nov 2004
    Consegnato il 07 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property k/a derativative interests in the motorway service areas on the east and west side of M3 motorway at shroner wood, martyr worthy, winchester, H. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 07 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a composite debenture dated 11 june 2004
    Creato il 22 nov 2004
    Consegnato il 26 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any of the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land k/a fuel forecourts and fuel shop at winchester msa M3 hampshire t/nos HP552876 and HP608068. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0