HAM BAKER ADAMS LIMITED

HAM BAKER ADAMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAM BAKER ADAMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04307534
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAM BAKER ADAMS LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova HAM BAKER ADAMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Frp Advisory Llp 2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAM BAKER ADAMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAM BAKER FLOW CONTROL LIMITED02 giu 200502 giu 2005
    HAM BAKER HARTLEY LIMITED19 ott 200119 ott 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAM BAKER ADAMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per HAM BAKER ADAMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 gen 2020

    16 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    6 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    24 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    17 pagineAM16

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    55 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Garner Street Etruria Stoke on Trent Staffordshire ST4 7BH a Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 27 feb 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    23 pagine2.12B

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    27 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 043075340010, creata il 01 ago 2016

    45 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 043075340009 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 nov 2015

    Stato del capitale al 13 nov 2015

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    29 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ott 2014

    Stato del capitale al 22 ott 2014

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    24 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HAM BAKER ADAMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIIAMS, Andrew
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    Segretario
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    187645280001
    RIGHTON, Robert Andrew
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    Amministratore
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    EnglandBritish51595850003
    WILLIAMS, Andrew
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    Amministratore
    2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Frp Advisory Llp
    EnglandBritish121597780002
    BRERETON, Gemma
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    169937170001
    COMBRINCK, Michael Andrew
    Esgair Farm Estate
    SY19 7DU Llanbrynmair
    Powys
    Segretario
    Esgair Farm Estate
    SY19 7DU Llanbrynmair
    Powys
    British28337100001
    HINDLEY, Michael
    Skegness Close
    BL8 1EQ Bury
    8
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Skegness Close
    BL8 1EQ Bury
    8
    Lancashire
    United Kingdom
    British97351080002
    LEWIS, John Arthur
    8 Brimhill Rise
    Chapmanslade
    BA13 4AX Westbury
    Wiltshire
    Segretario
    8 Brimhill Rise
    Chapmanslade
    BA13 4AX Westbury
    Wiltshire
    British23547320002
    WILLIAMS, Andrew
    55 Brookhouse Road
    WS5 3AE Walsall
    West Midlands
    Segretario
    55 Brookhouse Road
    WS5 3AE Walsall
    West Midlands
    British121597780001
    BAILIE, Stewart
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish108128510001
    BARTRAM, John Raymond
    40 Hollow Tree Road
    Hamilton
    LE5 1TH Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    40 Hollow Tree Road
    Hamilton
    LE5 1TH Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish27743370003
    BARTRAM, Stephen Walter
    36 Riverside Way
    Littlethorpe
    LE9 5PT Leicester
    Amministratore
    36 Riverside Way
    Littlethorpe
    LE9 5PT Leicester
    United KingdomBritish27743380002
    BROOKFIELD, Alan George
    Pen Y Graig
    Dolfach
    SY19 7AB Llanbrynmair
    Powys
    Amministratore
    Pen Y Graig
    Dolfach
    SY19 7AB Llanbrynmair
    Powys
    British105992270001
    BURDEN, Jeremy Paul
    Dumbleton Stores
    Main Road Dumbleton
    WR11 6TH Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Dumbleton Stores
    Main Road Dumbleton
    WR11 6TH Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish41792630001
    COMBRINCK, Michael Andrew
    Esgair Farm Estate
    SY19 7DU Llanbrynmair
    Powys
    Amministratore
    Esgair Farm Estate
    SY19 7DU Llanbrynmair
    Powys
    WalesBritish28337100001
    EATON, Darren
    92 Cecil Road
    WA15 9NX Hale, Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    92 Cecil Road
    WA15 9NX Hale, Altrincham
    Cheshire
    British70533940002
    HAMPTON, Alan Roger
    71 Bath Road
    Bridgeyate
    BS30 5NJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    71 Bath Road
    Bridgeyate
    BS30 5NJ Bristol
    Avon
    EnglandBritish11824960001
    HAMPTON, Alan Roger
    71 Bath Road
    Bridgeyate
    BS30 5NJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    71 Bath Road
    Bridgeyate
    BS30 5NJ Bristol
    Avon
    EnglandBritish11824960001
    HARRIS, Alister David
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish179670890001
    HOWARD, Edward Paul
    3 Gibb Road
    M28 2SS Worsley
    Manchester
    Amministratore
    3 Gibb Road
    M28 2SS Worsley
    Manchester
    EnglandBritish97237840001
    INNES, Daniel
    12 Sanquhar Gardens
    G53 7FR Glasgow
    Amministratore
    12 Sanquhar Gardens
    G53 7FR Glasgow
    ScotlandBritish80744190001
    MALLEN, Shyam
    Kirby Grindalythe
    YO17 8DB Malton
    The Old Chapel
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kirby Grindalythe
    YO17 8DB Malton
    The Old Chapel
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish166689140001
    WHELAN, Paul Edward
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    Amministratore
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    EnglandBritish143588500001
    WHELAN, Paul Edward
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    Amministratore
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    EnglandBritish143588500001
    WILLIAMS, Andrew
    55 Brookhouse Road
    WS5 3AE Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    55 Brookhouse Road
    WS5 3AE Walsall
    West Midlands
    British121597780001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAM BAKER ADAMS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ham Baker Limited
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke-On-Trent
    Garner Street Business Park
    England
    19 ott 2016
    Garner Street
    Etruria
    ST4 7BH Stoke-On-Trent
    Garner Street Business Park
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Autorità legaleCompanies Act
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HAM BAKER ADAMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2016
    Consegnato il 02 ago 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Security Trustee Services Limited
    Transazioni
    • 02 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 25 set 2014
    Consegnato il 01 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 ott 2013
    Consegnato il 25 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 25 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    All assets debenture
    Creato il 21 gen 2008
    Consegnato il 25 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 25 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 21 gen 2008
    Consegnato il 25 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 gen 2008
    Consegnato il 25 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 mar 2006
    Consegnato il 28 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 28 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 feb 2006
    Consegnato il 09 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 15 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 mar 2002
    Consegnato il 19 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HAM BAKER ADAMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 feb 2017Inizio dell'amministrazione
    03 gen 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Martin Stokes
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Russell Stewart Cash
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praticante
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Raj Mittal
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    2
    DataTipo
    03 gen 2019Inizio della liquidazione
    02 giu 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Arvindar Jit Singh
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Steven Martin Stokes
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Raj Mittal
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0