ROLLERDELL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROLLERDELL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04307781
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROLLERDELL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ROLLERDELL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7th Floor 9 Berkeley Street
    W1J 8DW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROLLERDELL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ROLLERDELL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da 3500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AL a 7th Floor 9 Berkeley Street London W1J 8DW in data 07 lug 2016

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 nov 2015

    Stato del capitale al 24 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2014

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2014

    Stato del capitale al 25 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 3Rd Floor 22 Grafton Street London W1S 4EX United Kingdom* in data 23 gen 2014

    2 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 nov 2013

    Stato del capitale al 11 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Sixth Floor 63 Curzon Street London W1J 8PD* in data 22 nov 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Cessazione della carica di Nigel Le Quesne come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Saffron Harrop come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roberto Monticelli come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Miranda Lansdowne come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Underwood-Whitney come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Burgin come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Castle Directors Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Nomina di Jtc Directors Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Dettagli del segretario cambiati per Jtc Management Limited il 21 mag 2012

    3 pagineCH04

    Nomina di Martin Gordon Cudlipp come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ROLLERDELL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JTC JERSEY LIMITED
    9 Castle Street
    St Helier
    JE4 2QP Jersey
    P O Box 1075 Elizabeth House
    Channel Isles
    Segretario
    9 Castle Street
    St Helier
    JE4 2QP Jersey
    P O Box 1075 Elizabeth House
    Channel Isles
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione37293
    160251780002
    CUDLIPP, Martin Gordon
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey Channel Islands
    JerseyBritish172570330001
    CASTLE DIRECTORS LIMITED
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Amministratore
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione102673
    170374650001
    JTC DIRECTORS LIMITED
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Amministratore
    9 Castle Street
    JE2 3RT St Helier
    Elizabeth House
    Jersey
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione100165
    170374460001
    ANDERSON, Samuel Kenneth
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    Segretario
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    British145693280001
    BRABNERS SECRETARIES LIMITED
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79429720001
    CAPITA TRUSTEES SERVICES LIMITED
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    Segretario
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    85248580003
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ANDERSON, Samuel Kenneth
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    Amministratore
    23 Brooklands Crescent
    Whitehead
    BT38 9SW Carrick Fergus
    British145693280001
    BARRETT, Linda Jane
    La Rue De Carteret
    Rue Des Pres St. Saviour
    JE2 7RA Jersey
    4
    Amministratore
    La Rue De Carteret
    Rue Des Pres St. Saviour
    JE2 7RA Jersey
    4
    British135027860001
    BAUDAINS, James Kenneth
    La Rue Mathurin
    Grouville
    JE3 9GZ Jersey
    Springvale
    Channel Isles
    Amministratore
    La Rue Mathurin
    Grouville
    JE3 9GZ Jersey
    Springvale
    Channel Isles
    British136150950001
    BLAMPIED, Michael Norman
    Rue De Guilleaume Et D'Anneville
    St.Martin
    JE3 6DP Jersey
    Perinne
    Channel Islands
    Amministratore
    Rue De Guilleaume Et D'Anneville
    St.Martin
    JE3 6DP Jersey
    Perinne
    Channel Islands
    UkBritish150439570001
    BURGIN, Philip Henry
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyEnglish120326900007
    CROSSLAND, Anne
    Daisy Hill House
    La Chevre Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    Amministratore
    Daisy Hill House
    La Chevre Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    British25971110004
    CROSSLAND, David
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    Amministratore
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    JerseyBritish3977330005
    CROWE, Anthony Charles
    La Cache De La Ronde
    Seapoint Le Grande Route De La Cote
    JE2 6BR St. Clement
    6
    Jersey
    Amministratore
    La Cache De La Ronde
    Seapoint Le Grande Route De La Cote
    JE2 6BR St. Clement
    6
    Jersey
    British135028380001
    DUCKWORTH, Roger Ian
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    British674980002
    FRY, Chrispian Francis Anstee
    Woodville Avenue
    St. Helier
    JE2 4AP Jersey
    40 Woodville Apartments
    Channel Isles
    Amministratore
    Woodville Avenue
    St. Helier
    JE2 4AP Jersey
    40 Woodville Apartments
    Channel Isles
    JerseyBritish191605130001
    GORROD, Joanne Louise
    Upper Kings Cliff
    St. Helier
    JE2 3GP Jersey
    2 Thornton Hall
    Channel Isles
    Amministratore
    Upper Kings Cliff
    St. Helier
    JE2 3GP Jersey
    2 Thornton Hall
    Channel Isles
    Jersey, Channel IslandsBritish175845830001
    HARROP, Saffron Louise
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish,120408490001
    LANSDOWNE, Miranda Suzanne Helen
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Jersey Channel IslandsBritish160253960001
    LE COUILLIARD, David Philip
    La Rue Des Pallieres
    St. Ouen
    JE3 2BB Jersey
    Le Passage
    Channel Isles
    Amministratore
    La Rue Des Pallieres
    St. Ouen
    JE3 2BB Jersey
    Le Passage
    Channel Isles
    Jersey Channel IslesBritish135028580001
    LE QUESNE, Nigel Anthony
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish71675010004
    MONTICELLI, Roberto
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish148791260001
    ROGERS, Peter John
    Fulmans Abbey Spring Lane
    Beaulieu
    SO42 7YT Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Fulmans Abbey Spring Lane
    Beaulieu
    SO42 7YT Brockenhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish143297040001
    TUGHAN, Frederick David
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Amministratore
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Northern IrelandBritish203412740001
    UNDERWOOD-WHITNEY, Anthony James
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Castle Street
    St Helier
    1075
    JE4 2QP Jersey
    Elizabeth House
    Channel Islands
    JerseyBritish160254210001
    WHEELER, Lorraine Fay
    La Rue Des Vignes
    St. Peter
    JE3 7YL Jersey
    L'Ailette
    Channel Isles
    Amministratore
    La Rue Des Vignes
    St. Peter
    JE3 7YL Jersey
    L'Ailette
    Channel Isles
    Channel IslandsBritish100921140001
    AIBJT CORPORATE LIMITED
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    Amministratore
    Aib House
    25 Esplanade
    JE2 3QA St Helier
    Channel Islands
    92635870003
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ROLLERDELL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Acession deed
    Creato il 06 gen 2006
    Consegnato il 18 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h or l/h property,its interest in any present or future licences,the rental income,all present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible moveable property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 18 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 2002
    Consegnato il 31 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a link 414, chestnut avenue, chandlers ford, eastleigh t/no. HP614206. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 lug 2002
    Consegnato il 31 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party legal charge
    Creato il 16 apr 2002
    Consegnato il 04 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from marlin investments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as link 414 chestnut ave,chandlers ford eastleigh hampshire; t/no HP605200; all buildings fixtures fittings fixed plant and machinery thereon; fixed charge over the benefit of all contracts,licence,right,covenant.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 04 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0