HRWF (LEEDS 1) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HRWF (LEEDS 1) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04318327 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HRWF (LEEDS 1) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 9th Floor 201 Bishopsgate EC2M 3BN London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GRANTCHESTER NOMINEES (LEEDS 1) LIMITED | 07 nov 2001 | 07 nov 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HRWF (LEEDS 1) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per HRWF (LEEDS 1) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael John Lawson Sales il 30 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Claire Louise Tily il 25 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Ian Bartram il 25 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Anthony Ussher il 25 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Griffiths il 25 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Th Re Corporate Secretarial Services Limited come segretario in data 01 apr 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Henderson Secretarial Services Limited come segretario in data 01 apr 2014 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AE in data 09 apr 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael John Lawson Sales il 27 lug 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Wallace Anderson come amministratore in data 28 mar 2013 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roger Benjamin Ely come amministratore in data 12 dic 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Michael Anthony Ussher come amministratore in data 12 dic 2012 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di William Wallace Anderson come amministratore | 4 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH RE CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom |
| 188415810001 | ||||||||||
| BARTRAM, Nigel Ian | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 147069720001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Mark | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 146681760001 | |||||||||
| SALES, Michael John Lawson | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 163411440001 | |||||||||
| TILY, Claire Louise | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 154521600001 | |||||||||
| USSHER, Michael Anthony | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | England | British | 174875400001 | |||||||||
| HENDERSON ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 | 73737310001 | |||||||||||
| CARPENTER, Venetia Caroline | Segretario nominato | Wanshurst Green Farm Marden TN12 9DF Tonbridge Kent | British | 900022970001 | ||||||||||
| HOLLOCKS, Ian Michael | Segretario | 22 Fairholme Avenue RM2 5UU Gidea Park Essex | British | 61055270001 | ||||||||||
| HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 | 6118210006 | |||||||||||
| ALFORD, Nicholas Brian Treseder | Amministratore | The Pines North Road HP4 3DX Berkhamsted Hertfordshire | Great Britain | British | 126970360001 | |||||||||
| ANDERSON, William Wallace | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 United Kingdom | England | British | 2894560001 | |||||||||
| ELY, Roger Benjamin | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 69707840001 | |||||||||
| EVANS, Christopher Mark Stephen | Amministratore delegato nominato | 12 Criffel Avenue Streatham Hill SW2 4AZ London | British | 900022960001 | ||||||||||
| HEWSON, Andrew Nicholas | Amministratore | Abesters Fernden Lane Blackdown GU27 3BS Haslemere Surrey | British | 8607090005 | ||||||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Amministratore | 15 Wildwood Road Hampstead Garden Suburb NW11 6UL London | England | British | 3470530003 | |||||||||
| WALTON, Timothy Paul | Amministratore | Ivy House Church Row Meole Brace SY3 9EY Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 59971310002 |
HRWF (LEEDS 1) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 18 ott 2006 Consegnato il 03 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h land to the east of great cambridge road. Enfield k/a as enfield retail park t/no EGL316564 and the l/h land and buildings on the north east side of great ancoats street, manchester, greater manchester k/a as central retail park t/no GM512140 and MAN39842 the f/h property k/a the belvedere retail park, brunton lane, newcastle-upon-tyne (including barratt house) t/nos TY360155, TY237793, TY13551 and TY233764 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 18 gen 2006 Consegnato il 03 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land to the east of great cambridge road enfield k/a enfield retail park t/n EGL316564 except for part, l/h land k/a central retail park great ancoats street manchester t/n GM512140, f/h land k/a the belvedere retail park brunton lane newcastle upon tyne t/n TY360155 and TY237793 for details of further properties charged please refer to form 395 all plant and machinery all monies all benefits in respect of the insurances all of its book and other debts first floating charge all its assets forming part of the trust fund. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A security agreement | Creato il 21 mar 2002 Consegnato il 03 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 1). all that freehold land on the north west side gelderd road birstall known as the west yorkshire retail park birstall t/no;-WYK621393 2). all that freehold land known as central retail park rooksley milton keynes T./no. BM219388 3). all that freehold land known as rooksley retail park milton keynes T./no;-BM203571 and all assets charged by way of fixed and floating charge under the terms of the charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0