HRWF (LEEDS 1) LIMITED

HRWF (LEEDS 1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHRWF (LEEDS 1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04318327
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HRWF (LEEDS 1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    9th Floor 201 Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GRANTCHESTER NOMINEES (LEEDS 1) LIMITED07 nov 200107 nov 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HRWF (LEEDS 1) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HRWF (LEEDS 1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 21 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 dic 2014

    Stato del capitale al 02 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael John Lawson Sales il 30 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Claire Louise Tily il 25 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Ian Bartram il 25 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Anthony Ussher il 25 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Griffiths il 25 lug 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Th Re Corporate Secretarial Services Limited come segretario in data 01 apr 2014

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Henderson Secretarial Services Limited come segretario in data 01 apr 2014

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AE in data 09 apr 2014

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 21 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Michael John Lawson Sales il 27 lug 2011

    3 pagineCH01

    Cessazione della carica di William Wallace Anderson come amministratore in data 28 mar 2013

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roger Benjamin Ely come amministratore in data 12 dic 2012

    2 pagineTM01

    Nomina di Michael Anthony Ussher come amministratore in data 12 dic 2012

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 21 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Nomina di William Wallace Anderson come amministratore

    4 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di HRWF (LEEDS 1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TH RE CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione08938611
    188415810001
    BARTRAM, Nigel Ian
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    United KingdomBritish147069720001
    GRIFFITHS, Mark
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    United KingdomBritish146681760001
    SALES, Michael John Lawson
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    United KingdomBritish163411440001
    TILY, Claire Louise
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    United KingdomBritish154521600001
    USSHER, Michael Anthony
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3BN London
    201
    United Kingdom
    EnglandBritish174875400001
    HENDERSON ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    73737310001
    CARPENTER, Venetia Caroline
    Wanshurst Green Farm
    Marden
    TN12 9DF Tonbridge
    Kent
    Segretario nominato
    Wanshurst Green Farm
    Marden
    TN12 9DF Tonbridge
    Kent
    British900022970001
    HOLLOCKS, Ian Michael
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    Segretario
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    British61055270001
    HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    6118210006
    ALFORD, Nicholas Brian Treseder
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Great BritainBritish126970360001
    ANDERSON, William Wallace
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    United Kingdom
    EnglandBritish2894560001
    ELY, Roger Benjamin
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    United Kingdom
    United KingdomBritish69707840001
    EVANS, Christopher Mark Stephen
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    Amministratore delegato nominato
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    British900022960001
    HEWSON, Andrew Nicholas
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    British8607090005
    HUBERMAN, Paul Laurence
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    Amministratore
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    EnglandBritish3470530003
    WALTON, Timothy Paul
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish59971310002

    HRWF (LEEDS 1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 03 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land to the east of great cambridge road. Enfield k/a as enfield retail park t/no EGL316564 and the l/h land and buildings on the north east side of great ancoats street, manchester, greater manchester k/a as central retail park t/no GM512140 and MAN39842 the f/h property k/a the belvedere retail park, brunton lane, newcastle-upon-tyne (including barratt house) t/nos TY360155, TY237793, TY13551 and TY233764 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hyp- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch as Agent and Trustees for Thefinance Parties
    • Bayerische Hyp- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch as Agent and Trustees for Thefinance Parties
    Transazioni
    • 03 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 18 gen 2006
    Consegnato il 03 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land to the east of great cambridge road enfield k/a enfield retail park t/n EGL316564 except for part, l/h land k/a central retail park great ancoats street manchester t/n GM512140, f/h land k/a the belvedere retail park brunton lane newcastle upon tyne t/n TY360155 and TY237793 for details of further properties charged please refer to form 395 all plant and machinery all monies all benefits in respect of the insurances all of its book and other debts first floating charge all its assets forming part of the trust fund. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 03 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 03 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1). all that freehold land on the north west side gelderd road birstall known as the west yorkshire retail park birstall t/no;-WYK621393 2). all that freehold land known as central retail park rooksley milton keynes T./no. BM219388 3). all that freehold land known as rooksley retail park milton keynes T./no;-BM203571 and all assets charged by way of fixed and floating charge under the terms of the charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branchas Agent and Trustee for the Finance Parties.
    Transazioni
    • 03 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0