BRIGHTSOURCE LIMITED

BRIGHTSOURCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRIGHTSOURCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04322798
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRIGHTSOURCE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BRIGHTSOURCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRIGHTSOURCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TARGET DIRECT PRINT LIMITED14 nov 200114 nov 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRIGHTSOURCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per BRIGHTSOURCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 15 feb 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Dividend declared 21/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Minh Tuan Huynh come amministratore in data 28 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Stuart Rowley come amministratore in data 09 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Barnaby Hosey come amministratore in data 28 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Emily Louise Gore come amministratore in data 28 dic 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    18 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Peter Frings come amministratore in data 22 dic 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    23 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Bentley il 30 ago 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2015

    Stato del capitale al 04 dic 2015

    • Capitale: GBP 67,402
    SH01

    Cessazione della carica di Mark Scott come amministratore in data 15 ott 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BRIGHTSOURCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUYNH, Minh Tuan
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    British119044790002
    BENTLEY, Mark
    Charterhouse Buildings
    EC1M 7AP London
    11-13
    England
    Amministratore
    Charterhouse Buildings
    EC1M 7AP London
    11-13
    England
    EnglandBritish121012880009
    JAMES, Guy Michael
    11 Lauriston Park
    The Park
    GL50 2QL Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    11 Lauriston Park
    The Park
    GL50 2QL Cheltenham
    Gloucestershire
    British55654870004
    NEWCOMBE, Marie
    3 Elm Lodge Woodleigh
    65 The Park
    GL50 2RY Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    3 Elm Lodge Woodleigh
    65 The Park
    GL50 2RY Cheltenham
    Gloucestershire
    British104459600001
    SAMUEL, Simon Robert
    117 Horns Road
    GL5 1EE Stroud
    Gloucestershire
    Segretario
    117 Horns Road
    GL5 1EE Stroud
    Gloucestershire
    British73712430002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CAROLAN, Andrew Joseph
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Amministratore
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    ScotlandBritish35083370004
    FRINGS, Peter Robert
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish124786890002
    FRITH, Susan Claire
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish102752630001
    GORE, Emily Louise
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish156338630002
    HOSEY, Barnaby
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish111155800001
    HUNDLEBY, Guy James Hamilton
    Torphin Road
    EH13 0HW Edinburgh
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Torphin Road
    EH13 0HW Edinburgh
    20
    United Kingdom
    ScotlandBritish50092640006
    HUYNH, Minh Tuan
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish119044790002
    JAMES, Guy Michael
    11 Lauriston Park
    The Park
    GL50 2QL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    11 Lauriston Park
    The Park
    GL50 2QL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish55654870004
    MARSHALL, Matthew Hughson
    1 Obelisk Cottages
    Hopetoun
    EH30 9SL South Queensferry
    West Lothian
    Amministratore
    1 Obelisk Cottages
    Hopetoun
    EH30 9SL South Queensferry
    West Lothian
    British121036490002
    MASON, Karen Bayley
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish156338590001
    NEWCOMBE, Marie
    3 Elm Lodge Woodleigh
    65 The Park
    GL50 2RY Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    3 Elm Lodge Woodleigh
    65 The Park
    GL50 2RY Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish104459600001
    PIDGEON, Stephen Meredith
    Hunt Court
    Sandy Pluck Lane
    GL53 5UB Shurdington
    Cheltenham
    Amministratore
    Hunt Court
    Sandy Pluck Lane
    GL53 5UB Shurdington
    Cheltenham
    United KingdomBritish51340510002
    ROWLEY, John Stuart
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    ScotlandBritish137045300001
    SAMUEL, Simon Robert
    117 Horns Road
    GL5 1EE Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    117 Horns Road
    GL5 1EE Stroud
    Gloucestershire
    British73712430002
    SCOTT, Mark Coleridge
    Petersham Road
    TW10 7AN Richmond
    Gort House
    London
    Amministratore
    Petersham Road
    TW10 7AN Richmond
    Gort House
    London
    United KingdomBritish132523740001
    SHEPPARD, Edward Henry
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    St James House
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish156338710001
    STEEDS, Kevin Barrie
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    Amministratore
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    British14119150003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRIGHTSOURCE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cello Signal Group Limited
    Charterhouse Buildings
    EC1M 7AP London
    11-13
    England
    06 apr 2016
    Charterhouse Buildings
    EC1M 7AP London
    11-13
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BRIGHTSOURCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 05 nov 2002
    Consegnato il 15 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from the company and/or all or any of the other companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 22 mar 2002
    Consegnato il 03 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 03 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0