BRIGHTSOURCE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRIGHTSOURCE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04322798 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRIGHTSOURCE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BRIGHTSOURCE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BRIGHTSOURCE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TARGET DIRECT PRINT LIMITED | 14 nov 2001 | 14 nov 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRIGHTSOURCE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per BRIGHTSOURCE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 15 feb 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Minh Tuan Huynh come amministratore in data 28 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di John Stuart Rowley come amministratore in data 09 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Barnaby Hosey come amministratore in data 28 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Emily Louise Gore come amministratore in data 28 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 18 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Frings come amministratore in data 22 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 23 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Bentley il 30 ago 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Scott come amministratore in data 15 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRIGHTSOURCE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUYNH, Minh Tuan | Segretario | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | British | 119044790002 | ||||||
| BENTLEY, Mark | Amministratore | Charterhouse Buildings EC1M 7AP London 11-13 England | England | British | 121012880009 | |||||
| JAMES, Guy Michael | Segretario | 11 Lauriston Park The Park GL50 2QL Cheltenham Gloucestershire | British | 55654870004 | ||||||
| NEWCOMBE, Marie | Segretario | 3 Elm Lodge Woodleigh 65 The Park GL50 2RY Cheltenham Gloucestershire | British | 104459600001 | ||||||
| SAMUEL, Simon Robert | Segretario | 117 Horns Road GL5 1EE Stroud Gloucestershire | British | 73712430002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CAROLAN, Andrew Joseph | Amministratore | 4 Blinkbonny Crescent EH4 3NB Edinburgh | Scotland | British | 35083370004 | |||||
| FRINGS, Peter Robert | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | England | British | 124786890002 | |||||
| FRITH, Susan Claire | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 102752630001 | |||||
| GORE, Emily Louise | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | England | British | 156338630002 | |||||
| HOSEY, Barnaby | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 111155800001 | |||||
| HUNDLEBY, Guy James Hamilton | Amministratore | Torphin Road EH13 0HW Edinburgh 20 United Kingdom | Scotland | British | 50092640006 | |||||
| HUYNH, Minh Tuan | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 119044790002 | |||||
| JAMES, Guy Michael | Amministratore | 11 Lauriston Park The Park GL50 2QL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 55654870004 | |||||
| MARSHALL, Matthew Hughson | Amministratore | 1 Obelisk Cottages Hopetoun EH30 9SL South Queensferry West Lothian | British | 121036490002 | ||||||
| MASON, Karen Bayley | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | England | British | 156338590001 | |||||
| NEWCOMBE, Marie | Amministratore | 3 Elm Lodge Woodleigh 65 The Park GL50 2RY Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 104459600001 | |||||
| PIDGEON, Stephen Meredith | Amministratore | Hunt Court Sandy Pluck Lane GL53 5UB Shurdington Cheltenham | United Kingdom | British | 51340510002 | |||||
| ROWLEY, John Stuart | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | Scotland | British | 137045300001 | |||||
| SAMUEL, Simon Robert | Amministratore | 117 Horns Road GL5 1EE Stroud Gloucestershire | British | 73712430002 | ||||||
| SCOTT, Mark Coleridge | Amministratore | Petersham Road TW10 7AN Richmond Gort House London | United Kingdom | British | 132523740001 | |||||
| SHEPPARD, Edward Henry | Amministratore | St James House St James Square GL50 3PR Cheltenham Gloucestershire | England | British | 156338710001 | |||||
| STEEDS, Kevin Barrie | Amministratore | 20 Fortismere Avenue Muswell Hill N10 3BL London | British | 14119150003 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRIGHTSOURCE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cello Signal Group Limited | 06 apr 2016 | Charterhouse Buildings EC1M 7AP London 11-13 England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
BRIGHTSOURCE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 19 dic 2007 Consegnato il 21 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 05 nov 2002 Consegnato il 15 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys and liabilities due or to become due from the company and/or all or any of the other companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All sums standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture | Creato il 22 mar 2002 Consegnato il 03 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0