APTED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAPTED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited'
    Numero di società 04326979
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di APTED?

    • Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione

    Dove si trova APTED?

    Indirizzo della sede legale
    7 Scott Building Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di APTED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    APTED LIMITED29 mag 201529 mag 2015
    OPEN COLLEGE NETWORK SOUTH WEST REGION LIMITED12 dic 200512 dic 2005
    OPEN COLLEGE NETWORK WEST LIMITED22 nov 200122 nov 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di APTED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per APTED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per APTED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 lug 2015

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Dr Vanessa Ann Gale il 01 nov 2015

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Amanda Charlton come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jo Birnie come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Matthew Browning come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Maria Harding come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paula Jones come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jane Acton come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Patricia Ann Day come amministratore in data 13 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sally Griffin come amministratore in data 02 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Thomas Farmer come amministratore in data 02 lug 2015

    1 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed apted LIMITED\certificate issued on 20/06/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name20 giu 2015

    Esenzione di cambio di nome" dall'uso di "limitata" o "cyfyngedig"

    NE01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 15 Research Way Derriford Plymouth PL6 8BT United Kingdom a 7 Scott Building Plymouth Science Park, Davy Road Derriford Plymouth PL6 8BX

    1 pagineAD02

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed open college network south west region LIMITED\certificate issued on 29/05/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name29 mag 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 20 mag 2015

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Research Way Derriford Plymouth Devon PL6 8BT a 7 Scott Building Plymouth Science Park, Davy Road Derriford Plymouth PL6 8BX in data 29 mag 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2014

    7 pagineAA

    Nomina di Ms Paula Jones come amministratore in data 15 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Maria Harding come amministratore in data 15 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Amanda Charlton come amministratore in data 15 apr 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di APTED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALE, Vanessa Ann, Dr
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Segretario
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    176850730001
    PHILLIPS, Marianne
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishCeo179714310001
    PUTIN, Andrew
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishSolicitor77930300001
    SIMMONS, Jonathan Patrick
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishFederation Director158920330001
    HARRISON, Richard John
    45 Fox Elms Road
    Tuffley
    GL4 0BG Gloucester
    Gloucestershire
    Segretario
    45 Fox Elms Road
    Tuffley
    GL4 0BG Gloucester
    Gloucestershire
    British93005420001
    WHITE, Marc Robert
    11 West Grove
    Montpelier
    BS6 5LS Bristol
    Segretario
    11 West Grove
    Montpelier
    BS6 5LS Bristol
    British72302100002
    ACTON, Jane
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishEthnobotanist105555090001
    ALAND, June Rosemary
    30 Mayfield Park South
    Fishponds
    BS16 3NG Bristol
    Amministratore
    30 Mayfield Park South
    Fishponds
    BS16 3NG Bristol
    EnglandBritishCoordinator90009810001
    BALLISAT, Adrian Howard
    Thorn Cottage
    Wembury
    PL9 0EF Plymouth
    Devon
    Amministratore
    Thorn Cottage
    Wembury
    PL9 0EF Plymouth
    Devon
    United KingdomBritishEducation Project Manager49684520001
    BIRNIE, Jo
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishFe Lecturer183410310001
    BOSCHERINI, Diana Rosalie Mary
    Heal House Farm
    Brent Road
    TA8 2JT Burnham On Sea
    Somerset
    Amministratore
    Heal House Farm
    Brent Road
    TA8 2JT Burnham On Sea
    Somerset
    BritishConsultant Education90009890001
    BOWERMAN, Elizabeth
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    England
    Amministratore
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    England
    United KingdomAmericanEducational Administrator156090600001
    BROWNING, James Matthew
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishDirector/Trustee125245610002
    CHANGIZI, Christine
    Clevedon Road
    Failand
    BS8 3UL Bristol
    69
    Avon
    United Kingdom
    Amministratore
    Clevedon Road
    Failand
    BS8 3UL Bristol
    69
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant138694440001
    CHARLTON, Amanda
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishHead Of Workforce Development196808380001
    COGAN, Emma
    Field Barn Drive
    DT4 0ED Weymouth
    20
    Dorset
    Amministratore
    Field Barn Drive
    DT4 0ED Weymouth
    20
    Dorset
    EnglandBritishFe Manager213829230001
    CROUDACE, Christopher Mark
    28 Lower Keyford
    BA11 4AS Frome
    Somerset
    Amministratore
    28 Lower Keyford
    BA11 4AS Frome
    Somerset
    United KingdomBritishLecturer90009900001
    DAY, Patricia Ann
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishFounder And Director35259720002
    DEE, Timothy Michael
    The Old House Hidcote Boyce
    GL55 6LX Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Old House Hidcote Boyce
    GL55 6LX Chipping Campden
    Gloucestershire
    BritishVice Principal At Hartbury Col50900930001
    EYTON, Rebecca
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    England
    Amministratore
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    England
    United KingdomBritishCollege Quality Manager162411180002
    FARMER, Michael Thomas
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    United KingdomBritishConsultant19001300002
    FITZGERALD, Vanessa
    Leyburn House
    Lower Manor Road
    TQ5 8HF Brixham
    Devon
    Amministratore
    Leyburn House
    Lower Manor Road
    TQ5 8HF Brixham
    Devon
    BritishLecturer107541300001
    GILLESPIE, Viv Anne
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    Amministratore
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    EnglandBritishPrincipal186436570001
    GOODMAN, Sabina Ann
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    England
    Amministratore
    Research Way
    Derriford
    PL6 8BT Plymouth
    15
    Devon
    England
    EnglandBritishConsultant111344560001
    GRIFFIN, Sally, Dr
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishHei162189150001
    HAMBLIN, John Andrew
    Fort Austin Avenue
    PL6 5TG Plymouth
    371
    Devon
    Amministratore
    Fort Austin Avenue
    PL6 5TG Plymouth
    371
    Devon
    EnglandBritishCeo134796790001
    HARDING, Maria
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishNon-Executive Director196808650001
    HUGHES, Marie Louise
    Church Road
    Filton
    BS34 7BD Bristol
    Tuc South West Church House
    England
    Amministratore
    Church Road
    Filton
    BS34 7BD Bristol
    Tuc South West Church House
    England
    EnglandBritishTrade Union Officer157007730001
    JONES, Paula
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    Amministratore
    Plymouth Science Park, Davy Road
    Derriford
    PL6 8BX Plymouth
    7 Scott Building
    England
    EnglandBritishCeo121065660001
    JORDAN, Patricia Ann
    3 The Hollies
    Holcombe Hill Holcombe
    BA3 5DH Radstock
    Somerset
    Amministratore
    3 The Hollies
    Holcombe Hill Holcombe
    BA3 5DH Radstock
    Somerset
    BritishLearning Consultant90010260001
    LEWIS, Clive Oscar
    122 Bath Road
    Cheltenham
    GL53 7JX Gloucestershire
    Amministratore
    122 Bath Road
    Cheltenham
    GL53 7JX Gloucestershire
    EnglandBritishDirector91777680001
    MOORE, Susan Barbara
    5 Lansdowne Square
    DT4 9QT Weymouth
    Dorset
    Amministratore
    5 Lansdowne Square
    DT4 9QT Weymouth
    Dorset
    EnglandBritishCollege Principal95541010001
    PAGETT, Tina, Dr
    Bythesea Road
    Trowbridge
    Wiltshire Council
    Wiltshire
    England
    Amministratore
    Bythesea Road
    Trowbridge
    Wiltshire Council
    Wiltshire
    England
    EnglandBritishEducational Senior Adviser188241450001
    PHILLIPS, Paul Lasseter, Dr
    20 Rockfield Glade
    Penhow
    NP26 3JF Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    20 Rockfield Glade
    Penhow
    NP26 3JF Chepstow
    Gwent
    WalesBritishPrincipal And Ce156403320001
    RICHARDS, Anne
    Truyere
    24 Station Road
    BS48 3NH Backwell
    North Somerset
    Amministratore
    Truyere
    24 Station Road
    BS48 3NH Backwell
    North Somerset
    BritishSenior Manager Fe College96890870001

    APTED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 27 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0