TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED

TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04328016
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Windsor House 42-50 42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TUBE LINES LIMITED28 gen 200228 gen 2002
    2164TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED23 nov 200123 nov 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 mag 2014

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Howard Ernest Carter come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Keith Williams come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daniel Moylan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    22 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Sir Peter Gerard Hendy il 12 mar 2013

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Christopher Garnett come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    20 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 31 mar 2011

    1 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O the Company Secretary the Sherard Building Edmund Halley Road Oxford Oxfordshire OX4 4DQ United Kingdom

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Risoluzioni

    Resolutions
    23 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    23 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARTER, Howard Earnest
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Segretario
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    British152621500001
    JONES, Martin Patrick William
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Segretario
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    British152674210001
    ALLEN, Stephen David
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Amministratore
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritish91156870001
    CARTER, Howard Ernest
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Amministratore
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    United KingdomBritish115261680003
    HENDY, Peter Gerard, Sir
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Amministratore
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritish62384480001
    LING, Elaine Linda Kirby
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    British103202830002
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Segretario
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Segretario
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    109588620001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ADAMS, Michael Augustine
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    Amministratore
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    EnglandBritish100265760001
    ADAMS, Michael Augustine
    Comforts Place
    Tandridge Lane
    RH7 6LW Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    Comforts Place
    Tandridge Lane
    RH7 6LW Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish100265760001
    BAILEY, Michael Cleveland
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    Amministratore
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    Canadian110217530001
    BASSILY, Fady Philip
    6 Physic Place
    Royal Hospital Road
    SW3 4HQ London
    Amministratore
    6 Physic Place
    Royal Hospital Road
    SW3 4HQ London
    Usa95885620001
    BEGG, David Andrew
    67 Victoria Wharf
    46 Narrow Street
    E14 8DD London
    Amministratore
    67 Victoria Wharf
    46 Narrow Street
    E14 8DD London
    EnglandBritish76645940003
    CARLISLE, Celia Diana
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    Amministratore
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    United KingdomBritish63756390001
    COPELAND, Ian Christopher
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    Amministratore
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    Usa80111500002
    CORBIN, Brian James
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    Amministratore
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    British87942120001
    COTTRELL, Keith
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritish88691090003
    CUNNINGHAM, Anthony
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135811090001
    DOVE, Robert Wallace
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    British80507460001
    ELKHOULY, Wael Nabil
    19 Acacia Avenue
    HA4 8RQ Eastcote
    Middlesex
    Amministratore
    19 Acacia Avenue
    HA4 8RQ Eastcote
    Middlesex
    Egyptian86216370001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Amministratore
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    British50174710001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Amministratore
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    British50174710001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish61515760002
    FENTON, Christopher Victor
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish114610580002
    FIELD, Malcolm David, Sir
    21 Embankment Gardens
    SW3 4LW London
    Amministratore
    21 Embankment Gardens
    SW3 4LW London
    EnglandBritish74857040002
    GARNETT, Christopher William Maxwell
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Amministratore
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritish120894870001
    GARTSHORE, Andrew Robert
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    Amministratore
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    New Zealander87942040001
    GORDON, Ray
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    British102379260001
    GRENFELL, Eric
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    Amministratore
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    American102348350001
    HUI, Carol
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish144634860001
    HYDE, Kevin Oliver
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    Amministratore
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    British66509100002
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Spanish93348510004
    LEZALA, Andrew Peter
    11 Finch Crescent
    Mickleover
    DE3 0TT Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    11 Finch Crescent
    Mickleover
    DE3 0TT Derby
    Derbyshire
    British85889200001

    TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge by way of assignment
    Creato il 12 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's rights in respect of clauses 3 and 4 of the equity subscription agreement dated 12TH may 2004. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 12 mag 2004
    Consegnato il 14 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to any borrower secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The borrower shares and the issuer shares, rights under the declaration trust, benefits by way of conversion, redemption, bonus, preference option or otherwise in respect of the borrower shares or any of the issuer shares floating charge undertaking and all property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Intermediary Corporation PLC as the Borrower Security Trustee
    Transazioni
    • 14 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Mortgage over shares
    Creato il 08 gen 2003
    Consegnato il 09 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from infraco jnp limited to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares being the 4,499,991 shares in the capital of the borrower issued in the name of the company and all rights moneys benefits and other properties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (London Branch) (as Security Trustee for the Senior Lenders)
    Transazioni
    • 09 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment agreement
    Creato il 31 dic 2002
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights in respect of clauses 3 (ebl subscription obligations) and 4 (security for ebl subscription obligations) of the equity subscription agreement.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A debenture and share mortgage
    Creato il 31 dic 2002
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of equitable mortgage and fixed charge the shares, by way of charge all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cit Group Structured Finance (UK) Limited as Mezzanine Security Trustee for Itself and Onbehalf of the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A floating charge and share mortgage
    Creato il 31 dic 2002
    Consegnato il 02 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares, all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. A first floating charge over the undertaking and all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (London Branch) the Security Trustee for the Senior Lenders
    Transazioni
    • 02 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 09 set 2002
    Consegnato il 19 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from jubilee rail limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of security the right to receive the amount of up to £11,933,933 (exclusive of value added tax) payable under or in connection with a letter agreement dated 28 august 2002. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0