TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04328016 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Windsor House 42-50 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TUBE LINES LIMITED | 28 gen 2002 | 28 gen 2002 |
| 2164TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 23 nov 2001 | 23 nov 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 mag 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Howard Ernest Carter come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Williams come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Moylan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Sir Peter Gerard Hendy il 12 mar 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Garnett come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 31 mar 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O the Company Secretary the Sherard Building Edmund Halley Road Oxford Oxfordshire OX4 4DQ United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 23 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 23 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTER, Howard Earnest | Segretario | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | British | 152621500001 | ||||||
| JONES, Martin Patrick William | Segretario | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | British | 152674210001 | ||||||
| ALLEN, Stephen David | Amministratore | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | England | British | 91156870001 | |||||
| CARTER, Howard Ernest | Amministratore | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | United Kingdom | British | 115261680003 | |||||
| HENDY, Peter Gerard, Sir | Amministratore | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | England | British | 62384480001 | |||||
| LING, Elaine Linda Kirby | Segretario | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | British | 103202830002 | ||||||
| SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | Meridian House The Crescent YO24 1AW York North Yorkshire | 70053320013 | |||||||
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford | 109588620001 | |||||||
| SISEC LIMITED | Segretario nominato | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||
| ADAMS, Michael Augustine | Amministratore | Pilgrim Street 5th Floor EC4V 6RN London 11 | England | British | 100265760001 | |||||
| ADAMS, Michael Augustine | Amministratore | Comforts Place Tandridge Lane RH7 6LW Lingfield Surrey | England | British | 100265760001 | |||||
| BAILEY, Michael Cleveland | Amministratore | Pilgrim Street 5th Floor EC4V 6RN London 11 United Kingdom | Canadian | 110217530001 | ||||||
| BASSILY, Fady Philip | Amministratore | 6 Physic Place Royal Hospital Road SW3 4HQ London | Usa | 95885620001 | ||||||
| BEGG, David Andrew | Amministratore | 67 Victoria Wharf 46 Narrow Street E14 8DD London | England | British | 76645940003 | |||||
| CARLISLE, Celia Diana | Amministratore | 163 Portland Road W11 4LR London | United Kingdom | British | 63756390001 | |||||
| COPELAND, Ian Christopher | Amministratore | Oakwood One Pine Street Apartment 2002 FOREIGN San Francisco California 94111 Usa | Usa | 80111500002 | ||||||
| CORBIN, Brian James | Amministratore | 71 Woodwarde Road Dulwich Village SE22 8UN London | British | 87942120001 | ||||||
| COTTRELL, Keith | Amministratore | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building | England | British | 88691090003 | |||||
| CUNNINGHAM, Anthony | Amministratore | Brafferton YO61 2NZ York The Old Vicarage North Yorkshire United Kingdom | England | British | 135811090001 | |||||
| DOVE, Robert Wallace | Amministratore | Tara Cavendish Road Saint Georges Hill KT13 0JT Weybridge Surrey | British | 80507460001 | ||||||
| ELKHOULY, Wael Nabil | Amministratore | 19 Acacia Avenue HA4 8RQ Eastcote Middlesex | Egyptian | 86216370001 | ||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Amministratore | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Amministratore | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||
| EWELL, Melvyn | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 61515760002 | |||||
| FENTON, Christopher Victor | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 114610580002 | |||||
| FIELD, Malcolm David, Sir | Amministratore | 21 Embankment Gardens SW3 4LW London | England | British | 74857040002 | |||||
| GARNETT, Christopher William Maxwell | Amministratore | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | England | British | 120894870001 | |||||
| GARTSHORE, Andrew Robert | Amministratore | 6 Jerningham Road Telegraph Hill SE14 5NX London | New Zealander | 87942040001 | ||||||
| GORDON, Ray | Amministratore | 29 Carrs Meadow Escrick YO19 6JZ York North Yorkshire | British | 102379260001 | ||||||
| GRENFELL, Eric | Amministratore | Pilgrim Street 5th Floor EC4V 6RN London 11 United Kingdom | American | 102348350001 | ||||||
| HUI, Carol | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 144634860001 | |||||
| HYDE, Kevin Oliver | Amministratore | 12 Mount Parade YO24 4AB York | British | 66509100002 | ||||||
| JOHNSON, Robert Nigel | Amministratore | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | 57954340003 | |||||
| LEO, Jose | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | 93348510004 | ||||||
| LEZALA, Andrew Peter | Amministratore | 11 Finch Crescent Mickleover DE3 0TT Derby Derbyshire | British | 85889200001 |
TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge by way of assignment | Creato il 12 mag 2004 Consegnato il 27 mag 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of the company's rights in respect of clauses 3 and 4 of the equity subscription agreement dated 12TH may 2004. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 12 mag 2004 Consegnato il 14 mag 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to any borrower secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The borrower shares and the issuer shares, rights under the declaration trust, benefits by way of conversion, redemption, bonus, preference option or otherwise in respect of the borrower shares or any of the issuer shares floating charge undertaking and all property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage over shares | Creato il 08 gen 2003 Consegnato il 09 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from infraco jnp limited to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The shares being the 4,499,991 shares in the capital of the borrower issued in the name of the company and all rights moneys benefits and other properties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment agreement | Creato il 31 dic 2002 Consegnato il 13 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its rights in respect of clauses 3 (ebl subscription obligations) and 4 (security for ebl subscription obligations) of the equity subscription agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A debenture and share mortgage | Creato il 31 dic 2002 Consegnato il 10 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of equitable mortgage and fixed charge the shares, by way of charge all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A floating charge and share mortgage | Creato il 31 dic 2002 Consegnato il 02 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The shares, all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. A first floating charge over the undertaking and all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment | Creato il 09 set 2002 Consegnato il 19 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from jubilee rail limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of security the right to receive the amount of up to £11,933,933 (exclusive of value added tax) payable under or in connection with a letter agreement dated 28 august 2002. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0