REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED

REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04330675
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 2462 LIMITED28 nov 200128 nov 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 mag 2022

    11 pagineLIQ03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 2nd Floor Building 3125 Century Way Thorpe Park Leeds LS15 8ZB

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ a C/O Mazars Llp 1st Floor Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 25 mag 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 mag 2021

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Notifica di Scarborough (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 09 apr 2021

    2 paginePSC02

    Cessazione di Scarborough Property Developments Limited come persona con controllo significativo il 09 apr 2021

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr Scott Richard Mccabe come amministratore in data 01 apr 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Esplanade Director Limited come amministratore in data 01 apr 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jeremy John Tutton come amministratore in data 01 apr 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 26 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Charles Mccabe come amministratore in data 26 mar 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 26 nov 2019

    3 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 28 feb 2019

    17 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 043306750010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 043306750009 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 28 feb 2018

    19 pagineAA

    Nomina di Mr Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 30 lug 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Euroap House
    England
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Euroap House
    England
    EnglandBritish151895310001
    TUTTON, Jeremy John
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    United KingdomBritish113787520002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Segretario
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Segretario
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Segretario
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    GILMAN, Peter John
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish35528040001
    MCCABE, Kevin Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    EnglandBritish109250000012
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    MCCABE, Simon Charles
    5 Rothesay Mews
    EH3 7SG Edinburgh
    Amministratore
    5 Rothesay Mews
    EH3 7SG Edinburgh
    British103888320001
    RICHARDSON, Paul
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Amministratore
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    United KingdomBritish133683730001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione6133267
    123430390001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Scarborough (Uk) Limited
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    09 apr 2021
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione7036722
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Scarborough Property Developments Limited
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    06 apr 2016
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneU.K.
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione7036711
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2014
    Consegnato il 11 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Crescent house 20 woodland road darlington t/no DU47667.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 feb 2014
    Consegnato il 27 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land and buildings k/a forsyth house 20 woodland road darlington t/no DU47667. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 mag 2012
    Consegnato il 08 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Rent deposit in the sum of £4,000 including an amount equal to vat in the sum of £800.
    Persone aventi diritto
    • Open Intelligence Services Limited
    Transazioni
    • 08 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 25 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each guarantor and the company to the refinancing fee beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Crescent house 20 woodland road darlington t/no DU47667 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Refinancing Fee Beneficiary
    Transazioni
    • 25 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 25 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Crescent house 20 woodland road darlington t/no DU47667 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 25 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 20 london road newbury t/no: BK236732 and f/h 22 london road newburyt/no: BK34290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H crescent house 20 woodland road darlington t/no: DU47667. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over cash deposit
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 21 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigns by way of security the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 2002
    Consegnato il 13 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a plot 1175 century way thorpe park leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 mar 2002
    Consegnato il 13 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 mag 2021Inizio della liquidazione
    20 ago 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Conrad Alexander Pearson
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0