REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04330675 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Mazars Llp 1st Floor Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INHOCO 2462 LIMITED | 28 nov 2001 | 28 nov 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 mag 2022 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 2nd Floor Building 3125 Century Way Thorpe Park Leeds LS15 8ZB | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ a C/O Mazars Llp 1st Floor Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 25 mag 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 7 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Notifica di Scarborough (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 09 apr 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Scarborough Property Developments Limited come persona con controllo significativo il 09 apr 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Nomina di Mr Scott Richard Mccabe come amministratore in data 01 apr 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Esplanade Director Limited come amministratore in data 01 apr 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeremy John Tutton come amministratore in data 01 apr 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Charles Mccabe come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 26 nov 2019 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2019 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 043306750010 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 043306750009 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 30 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire United Kingdom |
| 123430250001 | ||||||||||
| MCCABE, Scott Richard | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Euroap House England | England | British | 151895310001 | |||||||||
| TUTTON, Jeremy John | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | United Kingdom | British | 113787520002 | |||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Segretario | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | British | 1267050001 | ||||||||||
| MCCABE, Sandra | Segretario | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||||||
| TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 93 George Street EH2 3ES Edinburgh | 90707230001 | |||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Amministratore | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||||||
| GILMAN, Peter John | Amministratore | The Sashes Holgate Lane Boston Spa LS23 6BN Wetherby West Yorkshire | England | British | 35528040001 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | England | British | 109250000012 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 154915110001 | |||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Amministratore | 5 Rothesay Mews EH3 7SG Edinburgh | British | 103888320001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Amministratore | Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House 20 North Yorkshire | United Kingdom | British | 133683730001 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Amministratore | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| ESPLANADE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire United Kingdom |
| 123430390001 | ||||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 | |||||||||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarborough (Uk) Limited | 09 apr 2021 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Scarborough Property Developments Limited | 06 apr 2016 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 ago 2014 Consegnato il 11 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Crescent house 20 woodland road darlington t/no DU47667. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 19 feb 2014 Consegnato il 27 feb 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Land and buildings k/a forsyth house 20 woodland road darlington t/no DU47667. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 30 mag 2012 Consegnato il 08 giu 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £4,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Rent deposit in the sum of £4,000 including an amount equal to vat in the sum of £800. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 25 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each guarantor and the company to the refinancing fee beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Crescent house 20 woodland road darlington t/no DU47667 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 25 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor and the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Crescent house 20 woodland road darlington t/no DU47667 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 mar 2005 Consegnato il 07 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 20 london road newbury t/no: BK236732 and f/h 22 london road newburyt/no: BK34290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 mar 2005 Consegnato il 07 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H crescent house 20 woodland road darlington t/no: DU47667. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over cash deposit | Creato il 07 mar 2003 Consegnato il 21 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Assigns by way of security the deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 04 mar 2002 Consegnato il 13 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a plot 1175 century way thorpe park leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 mar 2002 Consegnato il 13 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
REMOTE PROPERTIES 1175 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0