SKD 5 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSKD 5 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04335936
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SKD 5 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SKD 5 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Commodity Quay
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SKD 5 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIX DEGREES UNIFIED COMMS (KAM) LIMITED30 set 201130 set 2011
    KEY ACCOUNT MANAGEMENT LIMITED07 dic 200107 dic 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di SKD 5 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per SKD 5 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Stylianos Karaolis come amministratore in data 11 mag 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Colin Manuel come amministratore in data 11 mag 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Keith Mitchell come amministratore in data 23 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stylianos Karaolis come amministratore in data 15 dic 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di David Michael Howson come amministratore in data 12 mag 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Crawley-Trice come amministratore in data 12 mag 2021

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2019 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Steven Keith Mitchell come amministratore in data 06 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Shanmuganathan come amministratore in data 06 mar 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kirsty Chapman come amministratore in data 06 mar 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Kirsty Chapman come amministratore in data 08 set 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SKD 5 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRAWLEY-TRICE, Simon
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish283625300001
    MANUEL, David Colin
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish78406280002
    BOOTH, Andrew Arnold
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Segretario
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    British163397970001
    MCNAMARA, Jenette
    6 Rivers House
    Kew Bridge Road
    TW8 0ES Brentford
    Essex
    Segretario
    6 Rivers House
    Kew Bridge Road
    TW8 0ES Brentford
    Essex
    British79624110001
    WHBC NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario nominato
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    900018580001
    CHAPMAN, Kirsty
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish237752510001
    HOWE, Adrian Trevor
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish130448940002
    HOWSON, David Michael
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish224111570001
    ING, Michael Andrew
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish199320020001
    KARAOLIS, Stylianos
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish290867510001
    LEWIS, Ian Anthony
    10 Nelmes Way
    RM11 2QZ Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    10 Nelmes Way
    RM11 2QZ Hornchurch
    Essex
    EnglandBritish165121930001
    MCNAMARA, Jenette
    6 Rivers House
    Kew Bridge Road
    TW8 0ES Brentford
    Essex
    Amministratore
    6 Rivers House
    Kew Bridge Road
    TW8 0ES Brentford
    Essex
    British79624110001
    MILLS, Alastair Richard
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish108612460004
    MITCHELL, Steven Keith
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish166684410001
    SHANMUGANATHAN, Jonathan
    Sandelswood End
    HP9 2NW Beaconsfield
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandelswood End
    HP9 2NW Beaconsfield
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118321380001
    SMITH, Ronald Watson
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish62182300001
    WHBC NOMINEE DIRECTORS LIMITED
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    900018570001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SKD 5 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Six Degrees Investments Limited
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    England
    06 apr 2016
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SKD 5 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 mar 2013
    Consegnato il 05 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the "Security Agent")
    Transazioni
    • 05 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 08 ago 2012
    Consegnato il 13 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company and each obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Penta Capital LLP (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 ott 2011
    Consegnato il 02 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Clydesdale Bank & Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 02 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 apr 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 ago 2011
    Consegnato il 25 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company and each obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Penta Capital LLP (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 24 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £19,681.25 in an interest bearing account in the name of the tenant and designated "9 st martin's court deposit account" with all interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Abbey Life Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating debenture
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 11 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Telia International Carrier UK Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0