PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED

PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04336523
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TELAVIN LIMITED07 dic 200107 dic 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 ago 2010

    9 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 03 ago 2010

    9 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 mag 2010

    6 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 nov 2009

    8 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    61 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    44 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2007

    24 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine395

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WEAVER, Jayne Marie
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    Segretario
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    British84919130001
    BRAZIER, Peter
    19 The Groves
    Riverside
    CH1 1SD Chester
    Cheshire
    Amministratore
    19 The Groves
    Riverside
    CH1 1SD Chester
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director90415850001
    GOULDING, Michael John
    4 Forestway
    PR25 1HL Leyland
    Amministratore
    4 Forestway
    PR25 1HL Leyland
    BritishCommercial Director126863270001
    LUCAS, Christa
    Woodlea
    Old Tram Road, Penwortham
    PR1 9TY Preston
    Amministratore
    Woodlea
    Old Tram Road, Penwortham
    PR1 9TY Preston
    EnglandSwissProduct Marketing Director126876280001
    O'CONNOR, Sean Stuart
    25 Finlay Street
    SW6 6HE London
    Amministratore
    25 Finlay Street
    SW6 6HE London
    EnglandBritishCompany Director20369370001
    WEAVER, Guy Michael Linsley
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    Amministratore
    49 Needham Drive
    CW4 8FB Cranage
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer84919050002
    MCGEE, Richard Andrew
    38 Berkley Close
    CO4 9RR Colchester
    Essex
    Segretario
    38 Berkley Close
    CO4 9RR Colchester
    Essex
    BritishAdministrator88095540001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    EASTWOOD, Janet
    81 Norwich Drive
    Upton
    L49 4GJ Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    81 Norwich Drive
    Upton
    L49 4GJ Wirral
    Merseyside
    BritishFinance Director41259340001
    HOLT, Tara
    Greenwood
    Blakemere Lane, Norley
    WA6 6NS Frodsham
    Amministratore
    Greenwood
    Blakemere Lane, Norley
    WA6 6NS Frodsham
    BritishMarketing Services Director126876290001
    MCGEE, John Joseph
    Aston Lodge, 22 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NU Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Aston Lodge, 22 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NU Chelmsford
    Essex
    BritishFinancial Consultant64773330001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 17 lug 2007
    Consegnato il 30 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £175,000 credited to account designation 17690366 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 apr 2007
    Consegnato il 19 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Sykes and Sarah Sykes
    Transazioni
    • 19 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 nov 2003
    Consegnato il 19 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 19 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 08 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    PREMIUM APPLIANCE BRANDS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 ago 2010Fine dell'amministrazione
    12 mag 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    David James Kelly
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0