TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED

TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04339626
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fifth Floor, The Urban Building
    3-9 Albert Street
    SL1 2BE Slough
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TYRRELLS POTATO CHIPS LIMITED13 dic 200113 dic 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Tyrrells Court Stretford Bridge Leominster Hereford HR6 9DQ a Fifth Floor, the Urban Building 3-9 Albert Street Slough SL1 2BE in data 21 giu 2019

    1 pagineAD01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 mar 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Andrew Steven Riddle come amministratore in data 25 mar 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Giles Alexander Glidden Henderson come amministratore in data 25 mar 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Janice Bennett come amministratore in data 25 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Malcolm Burns come amministratore in data 25 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Janice Bennett come segretario in data 25 mar 2019

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Kp Snacks Limited come persona con controllo significativo il 30 nov 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione di Tyrrells Group Limited come persona con controllo significativo il 30 nov 2018

    1 paginePSC07

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2018 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 dic 2017

    54 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Christopher Thorpe come amministratore in data 13 ago 2018

    2 pagineAP01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 27 giu 2018

    • Capitale: GBP 3,393,034
    5 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Chi sono gli amministratori di TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HENDERSON, Giles Alexander Glidden
    3-9 Albert Street
    SL1 2BE Slough
    Fifth Floor, The Urban Building
    England
    Amministratore
    3-9 Albert Street
    SL1 2BE Slough
    Fifth Floor, The Urban Building
    England
    EnglandBritishFinance Director175409820001
    RIDDLE, Andrew Steven
    3-9 Albert Street
    SL1 2BE Slough
    Fifth Floor, The Urban Building
    England
    Amministratore
    3-9 Albert Street
    SL1 2BE Slough
    Fifth Floor, The Urban Building
    England
    EnglandBritishSales Director175352040001
    THORPE, Mark Christopher
    3-9 Albert Street
    SL1 2BE Slough
    Fifth Floor, The Urban Building
    England
    Amministratore
    3-9 Albert Street
    SL1 2BE Slough
    Fifth Floor, The Urban Building
    England
    EnglandBritishDirector177004550001
    BENNETT, Janice
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    Segretario
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    224255000001
    HOUSTON, Andrew Alexander
    Flat 3 23 Baggallay Street
    HR4 0DZ Hereford
    Herefordshire
    Segretario
    Flat 3 23 Baggallay Street
    HR4 0DZ Hereford
    Herefordshire
    BritishAccountant57574520001
    JONES, Joanne Jennifer
    HR2 8RH Garway
    The Old Rectory
    Herefordshire
    Segretario
    HR2 8RH Garway
    The Old Rectory
    Herefordshire
    British129707030001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BENNETT, Janice
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    Amministratore
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    EnglandBritishGeneral Manager195749610001
    BURNS, Malcolm
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    Amministratore
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    United KingdomBritishBusiness Executive71185040008
    CHASE, William Leonard
    Tyrrells Court
    Stretford Ridge
    HR6 9DQ Leominster
    Herefordshire
    Amministratore
    Tyrrells Court
    Stretford Ridge
    HR6 9DQ Leominster
    Herefordshire
    EnglandBritishCommercial Director56612550001
    ESOM, Steven Derek
    Witheridge Hill
    Highmoor
    RG9 5PF Henley On Thames
    Witheridge Hill House
    Oxfordshire
    Amministratore
    Witheridge Hill
    Highmoor
    RG9 5PF Henley On Thames
    Witheridge Hill House
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director127069060001
    GARDNER, Sharon
    21st Ave Ne
    St Petersbury
    Florida
    556
    33704
    Usa
    Amministratore
    21st Ave Ne
    St Petersbury
    Florida
    556
    33704
    Usa
    UsaAmericanCompany Director153285280001
    JONES, Joanne Jennifer
    HR2 8RH Garway
    The Old Rectory
    Herefordshire
    Amministratore
    HR2 8RH Garway
    The Old Rectory
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director129707030001
    MILNER, David Richard
    NR23 1RN Holkham
    Park House
    Norfolk
    Amministratore
    NR23 1RN Holkham
    Park House
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director150546560001
    PARKINSON, Ian Thomas
    The Grove
    Haynall Lane Little Hereford
    SY8 4BG Ludlow
    Salop
    Amministratore
    The Grove
    Haynall Lane Little Hereford
    SY8 4BG Ludlow
    Salop
    EnglandBritishDirector100949280001
    SAYERS, Leslie
    St. Peters Road
    GL7 1RG Cirencester
    28
    Gloucestershire
    Amministratore
    St. Peters Road
    GL7 1RG Cirencester
    28
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director129706900001
    TELFORD, Stuart
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    Amministratore
    Tyrrells Court
    Stretford Bridge
    HR6 9DQ Leominster
    Hereford
    United KingdomBritishCompany Director224214630001
    WYNCOLL, Oliver Quentin James
    Fawnbrake Avenue
    Herne Hill
    SE24 0BG London
    117
    Amministratore
    Fawnbrake Avenue
    Herne Hill
    SE24 0BG London
    117
    United KingdomBritishNone103947630001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Albert Street
    SL1 2BE Slough
    3-9
    England
    30 nov 2018
    Albert Street
    SL1 2BE Slough
    3-9
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08314505
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Tyrrells Group Limited
    Stretford
    HR6 9DQ Leominster
    Tyrrells Court
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Stretford
    HR6 9DQ Leominster
    Tyrrells Court
    United Kingdom
    Forma giuridicaUk Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUk Company Law
    Luogo di registrazioneCompanies House, England & Wales
    Numero di registrazione05971755
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TYRRELLS POTATO CRISPS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 giu 2016
    Consegnato il 08 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    • Hsbc Bank PLC
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 ago 2013
    Consegnato il 04 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent (As Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 04 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 20 dic 2011
    Consegnato il 06 gen 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 mag 2010
    Consegnato il 14 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Langholm Capital LLP (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 14 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 12 ago 2008
    Consegnato il 19 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2008
    Consegnato il 18 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a tyrrells court, stretford bridge, leominster, herefordshire fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2008
    Consegnato il 18 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a tyrells court, stretford bridge, leominster, herefordshire fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 nov 2007
    Consegnato il 07 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 29 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the old fire station teme street tenbury wells worcestershire t/no WR93190.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 gen 2007
    Consegnato il 06 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £411,206.66 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Kmg systems LTD third seasoning packing station comprising conveyor s/n emc 2 G08101 conveyor s/n emc 2 G08012 conveyor s/n emc 2 G08012 for details of further properties charged please refer to form 395 together with all accessories component parts books manuals technical data. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 feb 2006
    Consegnato il 14 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £862,981.93 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The items being detailed assets description sormac bv abrasive peeling line serial no. 051182-051352 1 x tna robag 3T x 320RDJRH machine T300-1587-l 514 delta scale for further details of goods charge please refer to the form 395 together with all accessories and component parts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 2006
    Consegnato il 25 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The laddin farm little marcle herefordshire HR8 2LB.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 2005
    Consegnato il 01 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 set 2005
    Consegnato il 07 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Great marston farm risbury leominster herfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 2005
    Consegnato il 17 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £202,180.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    138F star and garter mews corve street ludlow shropshire SY8 2PG t/n SL149887.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 2005
    Consegnato il 15 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £202,180.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Former fire station teme street tenbury wells worcestershire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2005
    Consegnato il 05 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 52 teme street, tenbury wells, worcestershire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2005
    Consegnato il 05 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the old agricultural market, tenbury wells.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 06 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Tna robag 2CI vffs & tna 414 snx multihead weigher s/no: T223 1012L & WG0202567.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 06 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0