TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED

TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04346502
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THISTLE EDINBURGH LIMITED01 mar 200201 mar 2002
    PETERTRAIL LIMITED03 gen 200203 gen 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mag 2013
    Scadenza dei prossimi bilanci il28 feb 2014
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 gen 2017

    8 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 nov 2016

    10 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    5 pagine600

    legacy

    2 pagineAC93

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 set 2014

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 mar 2014

    8 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 07 gen 2013

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2013

    Stato del capitale al 07 gen 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2012

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 03 apr 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2010

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOHARM, Cheryl Frances
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Segretario
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary74265400001
    BUSH, Clive Edward
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Amministratore
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor62062860002
    MOHARM, Cheryl Frances
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Amministratore
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary74265400003
    ZAKAY, Eddie
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Amministratore
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director8477470004
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director27825440001
    CATTERMOLE, Ian Kendall
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary82666030001
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Segretario
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    British150020002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director27825440001
    CATTERMOLE, Ian Kendall
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary82666030001
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Amministratore
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director150020002
    FAIRLEY, Neil Duff
    72 Carr Road
    Calverley
    LS28 5RH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    72 Carr Road
    Calverley
    LS28 5RH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant78198900001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MOK, Rayman
    PO BOX 44790
    101 Buckingham Palace Road
    SW1W 0WA London
    Amministratore
    PO BOX 44790
    101 Buckingham Palace Road
    SW1W 0WA London
    SingaporeanChief Financial Officer101871540001
    NEWSOME, Gillian Anne
    15 Layton Lane
    Rawdon
    LS19 6RQ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Layton Lane
    Rawdon
    LS19 6RQ Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant70404230001
    O'MAHONEY, Michael
    44 Beechcroft Manor
    KT13 9NZ Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    44 Beechcroft Manor
    KT13 9NZ Weybridge
    Surrey
    BritishDirector84990810001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    WILDEN, Nichola Jane
    12c Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    Amministratore
    12c Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    EnglandBritishChartered Accountant24856300002
    ZAKAY, Sol
    46 Avenue Road
    NW8 6HS London
    Amministratore
    46 Avenue Road
    NW8 6HS London
    United KingdomBritishCompany Director26053220007

    TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A standard security presented for registration in scotland on the 3RD may 2005 and
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 18 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limted to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the tenants interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh being the lease between murrayfield (tolcross) limited and scottish and newcastle breweries limited dated the 6TH may, 11TH july and 9TH august 1974. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 18 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignation of rents on 4TH may 2005
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 18 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company`s whole right title and interest in and to the rent and all other monies due and to become due to the company in terms of the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh dated the 28TH april 2005. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 18 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenant's interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh t/no MID22327. By way of fixed charge all moneys standing to the credit of the charged accounts, the benefits in respect of the insurances, all rights under each occupational lease, the benefit of all licences, all rights under the assigned agreements, all shares and related rights. By way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 apr 2017Data prevista di scioglimento
    04 mar 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0