TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED
Panoramica
Nome della società | TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04346502 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
THISTLE EDINBURGH LIMITED | 01 mar 2002 | 01 mar 2002 |
PETERTRAIL LIMITED | 03 gen 2002 | 03 gen 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 mag 2013 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 28 feb 2014 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 gen 2017 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 nov 2016 | 10 pagine | 4.68 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 5 pagine | 600 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AC93 | ||||||||||
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 set 2014 | 6 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 mar 2014 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 07 gen 2013 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 03 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHARM, Cheryl Frances | Segretario | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | British | Company Secretary | 74265400001 | |||||
BUSH, Clive Edward | Amministratore | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 62062860002 | ||||
MOHARM, Cheryl Frances | Amministratore | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 74265400003 | ||||
ZAKAY, Eddie | Amministratore | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 8477470004 | ||||
BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Segretario | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | Company Director | 27825440001 | |||||
CATTERMOLE, Ian Kendall | Segretario | Spindlewood Coppins Close HP4 3NZ Berkhamsted Hertfordshire | British | Chartered Secretary | 82666030001 | |||||
DURANT, Ian Charles | Segretario | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | British | 150020002 | ||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Amministratore | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | Company Director | 27825440001 | |||||
CATTERMOLE, Ian Kendall | Amministratore | Spindlewood Coppins Close HP4 3NZ Berkhamsted Hertfordshire | British | Chartered Secretary | 82666030001 | |||||
DURANT, Ian Charles | Amministratore | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 150020002 | ||||
FAIRLEY, Neil Duff | Amministratore | 72 Carr Road Calverley LS28 5RH Leeds West Yorkshire | England | British | Accountant | 78198900001 | ||||
LAYTON, Matthew Robert | Amministratore delegato nominato | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
MOK, Rayman | Amministratore | PO BOX 44790 101 Buckingham Palace Road SW1W 0WA London | Singaporean | Chief Financial Officer | 101871540001 | |||||
NEWSOME, Gillian Anne | Amministratore | 15 Layton Lane Rawdon LS19 6RQ Leeds West Yorkshire | British | Accountant | 70404230001 | |||||
O'MAHONEY, Michael | Amministratore | 44 Beechcroft Manor KT13 9NZ Weybridge Surrey | British | Director | 84990810001 | |||||
RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
WILDEN, Nichola Jane | Amministratore | 12c Elsworthy Terrace NW3 3DR London | England | British | Chartered Accountant | 24856300002 | ||||
ZAKAY, Sol | Amministratore | 46 Avenue Road NW8 6HS London | United Kingdom | British | Company Director | 26053220007 |
TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A standard security presented for registration in scotland on the 3RD may 2005 and | Creato il 28 apr 2005 Consegnato il 18 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limted to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the tenants interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh being the lease between murrayfield (tolcross) limited and scottish and newcastle breweries limited dated the 6TH may, 11TH july and 9TH august 1974. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of rents on 4TH may 2005 | Creato il 28 apr 2005 Consegnato il 18 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company`s whole right title and interest in and to the rent and all other monies due and to become due to the company in terms of the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh dated the 28TH april 2005. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 28 apr 2005 Consegnato il 07 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The tenant's interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh t/no MID22327. By way of fixed charge all moneys standing to the credit of the charged accounts, the benefits in respect of the insurances, all rights under each occupational lease, the benefit of all licences, all rights under the assigned agreements, all shares and related rights. By way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0