COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04347362 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Rubicon 8-12 York Gate NW1 4QG London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ashwood Court Springwood Way Tytherington Business Park Macclesfield Cheshire SK10 2XF a C/O Rubicon 8-12 York Gate London NW1 4QG in data 07 apr 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Christopher Humphreys come amministratore in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Lee Cruddace come amministratore in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Darrell Fox come segretario in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Christopher Humphreys come segretario in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Darrell Fox come amministratore in data 05 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Perkins come amministratore in data 05 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Wellfield House Victoria Road Churwell Morley Leeds West Yorkshire LS27 7PA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Mr David Christopher Humphreys come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Hertsmere House Shenley Road Borehamwood Hertfordshire WD6 1TE United Kingdom* in data 04 dic 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Owens come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Christopher Humphreys come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX, Darrell | Segretario | 8-12 York Gate NW1 4QG London C/O Rubicon England | 220799160001 | |||||||
| FOX, Darrell | Amministratore | 8-12 York Gate NW1 4QG London C/O Rubicon England | England | British | 56378250001 | |||||
| PERKINS, Mark | Amministratore | 8-12 York Gate NW1 4QG London C/O Rubicon England | United Kingdom | British | 85890200002 | |||||
| HUMPHREYS, David Christopher | Segretario | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court Cheshire England | 173816740001 | |||||||
| JOHNSTONE, Lee | Segretario | Shenley Road WD6 1TE Borehamwood Hertsmere House Hertfordshire United Kingdom | 156517440001 | |||||||
| JOHNSTONE, Lee | Segretario | 16 Mulberry Way Northowram HX3 7WJ Halifax West Yorkshire | British | 105435350001 | ||||||
| KERSHAW, Christopher Graham | Segretario | 7 Evesham Grove Idle BD10 8TN Bradford | British | 63085680001 | ||||||
| LIGHTOWLERS, Oliver James | Segretario | 2 Leadhall Close HG2 9PQ Harrogate North Yorkshire | British | 86517930001 | ||||||
| MORTON, Julia Alison | Segretario | Kingsdown Close Wychwood Park CW2 5FX Weston 5 Cheshire | British | 141157110001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Liam | Segretario | Shenley Road WD6 1TE Borehamwood Hertsmere House Hertfordshire United Kingdom | 165549020001 | |||||||
| RAWCLIFFE AND CO. FORMATIONS LIMITED | Segretario nominato | West Park House 7-9 Wilkinson Avenue FY3 9XG Blackpool Lancashire | 900017540001 | |||||||
| CHAMBERS, Carl James | Amministratore | The Old Farmhouse 73-75 Breary Lane East LS16 9EU Bramhope Leeds West Yorkshire | England | British | 257019520001 | |||||
| CRUDDACE, David Lee, Mr. | Amministratore | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court Cheshire England | England | British | 165544960001 | |||||
| HUMPHREYS, David Christopher | Amministratore | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court Cheshire England | United Kingdom | British | 117192120002 | |||||
| JOHNSTONE, Lee | Amministratore | Shenley Road WD6 1TE Borehamwood Hertsmere House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 105435350001 | |||||
| OLIVER, Ian David | Amministratore | 81 Belvoir Drive LE2 8PB Leicester Leicestershire | British | 80195030001 | ||||||
| OWENS, David William | Amministratore | Shenley Road WD6 1TE Borehamwood Hertsmere House Hertfordshire United Kingdom | England | British | 110731260001 | |||||
| RIGBY, William Simon | Amministratore | Springwood Scotchman Lane Morley LS27 0NZ Leeds Yorkshire | United Kingdom | British | 48515290001 | |||||
| TATE, Wendy | Amministratore | Wellfield House Victoria Road Morley LS27 7PA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 103094250002 | |||||
| RAWCLIFFE AND CO. COMPANY SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | West Park House 7/9 Wilkinson Avenue FY3 9XG Blackpool Lancashire | 900013030001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enserve Group Limited | 06 apr 2016 | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 12 ott 2006 Consegnato il 24 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from spice PLC and each of its subsidiaries from time to time to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 feb 2002 Consegnato il 26 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0