CELLNOVO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCELLNOVO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04349221
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CELLNOVO LIMITED?

    • Fabbricazione di strumenti e forniture medico-chirurgiche (32500) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CELLNOVO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CELLNOVO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STARBRIDGE SYSTEMS LIMITED05 mar 200205 mar 2002
    STARBARGE LIMITED08 gen 200208 gen 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di CELLNOVO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CELLNOVO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    24 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    16 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    11 pagineAM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    41 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Pencoed Technology Centre Pencoed Technology Park Bridgend CF35 5HZ Wales a C/O Rsm Restructuring Advisory Llp the Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1BP in data 16 apr 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 dic 2018

    • Capitale: GBP 46,333,996
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 043492210018, creata il 28 ago 2018

    67 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 043492210017, creata il 31 lug 2018

    59 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    39 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 15 dic 2017

    • Capitale: GBP 37,427,214
    3 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    20 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 043492210015, creata il 08 mag 2017

    31 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 043492210016, creata il 08 mag 2017

    26 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    39 pagineAA

    Cessazione della carica di John Gethin come amministratore in data 13 feb 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di CELLNOVO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EDWARDS, Darren John
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    C/O Rsm Restructuring Advisory Llp
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    C/O Rsm Restructuring Advisory Llp
    Buckinghamshire
    200783770001
    BARATTE, Sophie
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    C/O Rsm Restructuring Advisory Llp
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    C/O Rsm Restructuring Advisory Llp
    Buckinghamshire
    EnglandFrench200783050001
    BERGSTEIN, Lambertus, Mr.
    Pencoed Technology Park
    CF35 5HZ Bridgend
    Sony Technology Centre
    Mid Glamorgan
    Wales
    Segretario
    Pencoed Technology Park
    CF35 5HZ Bridgend
    Sony Technology Centre
    Mid Glamorgan
    Wales
    196995570001
    BURNISTON, Bruce Humphrey
    22 East Cliff
    Southgate
    SA3 2AS Swansea
    Segretario
    22 East Cliff
    Southgate
    SA3 2AS Swansea
    British81517170001
    HAINES, David
    11 Baynton Close
    Llandaff
    CF5 2NZ Cardiff
    Segretario
    11 Baynton Close
    Llandaff
    CF5 2NZ Cardiff
    British72911860001
    JONES, Nigel Lanyon
    123 Maes Ty Canol
    Baglan
    SA12 8US Port Talbot
    Segretario
    123 Maes Ty Canol
    Baglan
    SA12 8US Port Talbot
    British78712490001
    LAZARUS, Heather Ann
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    Segretario nominato
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    British900001810001
    MCKEON, William Francis
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    Segretario
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    United States134135740001
    SHAPLEY, Julian Douglas Llewellyn, Dr
    33 Gelligaer Street
    Cathays
    CF24 4LD Cardiff
    Segretario
    33 Gelligaer Street
    Cathays
    CF24 4LD Cardiff
    British81739860001
    SIGGER, Jan Willem Hendrik
    Victoria Quay
    Maritime Quarter
    SA1 3XA Swansea
    20
    Segretario
    Victoria Quay
    Maritime Quarter
    SA1 3XA Swansea
    20
    British171834880001
    WELLS, Rachel Joanne
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Segretario
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    174018850001
    BEARD, Eric
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    BelgiumBritish264657790001
    BENJAMIN, Jerry Christopher
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    Greater London
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    Greater London
    United KingdomUnited States132434090001
    BERGSTEIN, Lambertus Paulus Antonius
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    The NetherlandsDutch158350050001
    BURNISTON, Bruce Humphrey
    22 East Cliff
    Southgate
    SA3 2AS Swansea
    Amministratore
    22 East Cliff
    Southgate
    SA3 2AS Swansea
    British81517170001
    CEFAI, Joseph John, Mr.
    The Laurels Quarry Road
    Treboeth
    SA5 9DJ Swansea
    Amministratore
    The Laurels Quarry Road
    Treboeth
    SA5 9DJ Swansea
    United KingdomBritish81739790001
    CLEMENT, Robert Marc
    11 Plas Road
    Rhos Pontardawe
    SA8 3HD Swansea
    Amministratore
    11 Plas Road
    Rhos Pontardawe
    SA8 3HD Swansea
    United KingdomBritish25145750001
    CONSTANTINIDES, Aris
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    EnglandBritish118033860002
    GARIBOTTO, John Thomas
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    UsaAmerican194120400001
    GETHIN, John
    Pencoed Technology Park
    CF35 5HZ Bridgend
    Pencoed Technology Centre
    Wales
    Amministratore
    Pencoed Technology Park
    CF35 5HZ Bridgend
    Pencoed Technology Centre
    Wales
    WalesBritish201600870001
    HAINES, David
    11 Baynton Close
    Llandaff
    CF5 2NZ Cardiff
    Amministratore
    11 Baynton Close
    Llandaff
    CF5 2NZ Cardiff
    United KingdomBritish72911860001
    LAZARUS, Harry Pierre
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    Amministratore delegato nominato
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    British900001820001
    LITTLECHILD, John
    Sony (Uk) Technology Centre
    Pencoed Technology Park
    CF35 5HZ Bridgend
    C/O Cellnovo Ltd
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    Sony (Uk) Technology Centre
    Pencoed Technology Park
    CF35 5HZ Bridgend
    C/O Cellnovo Ltd
    Mid Glamorgan
    Wales
    UsaUnited States136172400001
    MARTINEAU, Peter Michael Corser
    25 Falcon Close
    Westbury On Trym
    BS9 3NH Bristol
    Amministratore
    25 Falcon Close
    Westbury On Trym
    BS9 3NH Bristol
    EnglandBritish87086150001
    MCKEON, William Francis
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    United KingdomUnited States134135740002
    MILAD, John Eric
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    UkBritish-American107728920002
    NURNBERG, Steve
    141 Dean Avenue
    Franklin
    Massachusetts 02038
    Usa
    Amministratore
    141 Dean Avenue
    Franklin
    Massachusetts 02038
    Usa
    American83639850001
    PAREKH, Raj, Dr
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    United KingdomBritish137178640001
    PELTIER, Philippe Maurice Anselme
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    FranceFrench158350320001
    REITHINGER, Holger, Dr
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    NetherlandsGerman189954670001
    SCHMIDT, Meinhard
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    Amministratore
    c/o Cellnovo Limited
    Kings Road
    SA1 8AS Swansea
    Ethos
    Wales
    SwitzerlandGerman164386530001
    SHAPLEY, Julian Douglas Llewellyn, Dr
    33 Gelligaer Street
    Cathays
    CF24 4LD Cardiff
    Amministratore
    33 Gelligaer Street
    Cathays
    CF24 4LD Cardiff
    UkBritish81739860001
    SIMONSEN, Jan Henning
    Sarpsborgvej 6
    7600 Struer
    Denmark
    Amministratore
    Sarpsborgvej 6
    7600 Struer
    Denmark
    Danish88994500001
    SMITH, Kevin Stephen
    72 Brynteg Road
    Gorseinon
    SA4 4FR Swansea
    West Glamorgan
    Amministratore
    72 Brynteg Road
    Gorseinon
    SA4 4FR Swansea
    West Glamorgan
    WalesBritish71323010001
    TAYLOR, Alistair Henderson
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6LD London
    25
    United KingdomBritish70878740009

    Chi sono le persone con controllo significativo di CELLNOVO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cellnovo Sa
    Rue De Londres
    75009 Paris
    13
    France
    06 apr 2016
    Rue De Londres
    75009 Paris
    13
    France
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneFrance
    Autorità legaleFrench Law
    Luogo di registrazioneRcs Paris
    Numero di registrazione808 426 662
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CELLNOVO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 ago 2018
    Consegnato il 30 ago 2018
    In corso
    Breve descrizione
    Schedule 1 patents - 1 "micro-valve" patent family. This patent family covers the design and construction of micro-valve fluid systems essential to the proper functioning and the safety of the cellnovo pump. Country: royaume-uni; status: brevetdélivré;patentee: cellnovo LTD; priority: -; date and filing number 26.10.2006 GB 0621343.3; publication number: GB 2443260;expiration date: 26.10.2026; comments – for details of. Further property charged please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital V (UK) Limited
    Transazioni
    • 30 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 lug 2018
    Consegnato il 18 ago 2018
    In corso
    Breve descrizione
    The following trademarks: mdm registered in eu number 009942632; C.online registered in eu number 012422069; cellnovo published subject to an objection from novo nordisk a/s in eu number 008136921, and registered in usa number 77708262; and C.pal registered in eu number 012422085.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital V (UK) Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 08 mag 2017
    Consegnato il 23 mag 2017
    In corso
    Breve descrizione
    Patent granted in the UK, publication number GB 2443260 and others listed in paragraphs 1 and 2 of schedule 1 to the instrument. For more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital V (UK) Limited (Company Number 9728300)
    Transazioni
    • 23 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 08 mag 2017
    Consegnato il 23 mag 2017
    In corso
    Breve descrizione
    The following trademarks: mdm registered in eu number 009942632, and others as set out in the instrument.. The following domain name: www.cellnovo.com, and others as set out in the instrument.. For full details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital V (UK) Limited (Company Number 9728300)
    Transazioni
    • 23 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 lug 2015
    Consegnato il 23 lug 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The chargor charges to the lender by way of first fixed charge all present and future right, title and interest of the borrower in and to the intellectual property which is at any time owned by the borrower or in which the borrower from time to time has an interest. Intellectual property is defined as the patents (defined in the instrument as the patents listed in paragraphs 1, 2, 8 and 9 of schedule 1 to the instrument), including a registered patent with publication number GB 2443260, and derived rights (defined in the instrument as all applications and patents claiming priority from and otherwise based on inventions disclosed in the patents). Please see the instrument for further details.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital Iv (UK) Limited (the Lender)
    Transazioni
    • 23 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 lug 2015
    Consegnato il 22 lug 2015
    In corso
    Breve descrizione
    1. the chargor charges to the lender by way of first legal mortgage all freehold, leasehold (with an unexpired term of more than five years) or other immovable property now vested in or charged to the borrower. 2. the chargor charges to the lender by way of first fixed charge all other freehold, leasehold and other immovable property now or in the future belonging to the borrower. 3. the chargor charges to the lender by way of first fixed charge the benefit of all intellectual property. Please see the instrument for more details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital Iv (UK) Limited (the Lender)
    Transazioni
    • 22 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 17 gen 2011
    Consegnato il 21 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000.00 and all other monies due or to become due from the company to each of the noteholders and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Nominees Limited, Healthcare Ventures Viii LP & Advent Management Iv Limited Partnership
    Transazioni
    • 21 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation of a debenture
    Creato il 26 nov 2010
    Consegnato il 03 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,000,000 and all other monies due or to become due from the company to each of the noteholders and security agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Nominees Limited and Advent Private Equity Fund Iv LP
    Transazioni
    • 03 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 ott 2010
    Consegnato il 29 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000 and all monies due or to become due from the company to each of the noteholders and security agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Nominees Limited, Advent Private Equity Fund Iv LP, Healthcare Ventures Viii LP, and Advent Management Iv Limited Partnership
    Transazioni
    • 29 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation of a debenture dated 21 july 2010
    Creato il 17 set 2010
    Consegnato il 23 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,833.334 and all other monies due or to become due from the company to each of the noteholders and security agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Nominees Limited Advent Private Equity Fund Iv LP Healthcare Ventures Viii LP and Advent Management Iv Limited Partnership
    Transazioni
    • 23 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation of a debenture dated 21 july 2010 and
    Creato il 18 ago 2010
    Consegnato il 20 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,833,334 and all other monies due or to become due from the company to each of the noteholders and security agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Nominees Limited Advent Private Equity Fund Iv LP Healthcare Ventures Viii LP and Advent Management Iv Limited Partnership
    Transazioni
    • 20 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 23 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each of the noteholders and security agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Nominees Limited and Advent Private Equity Fund Iv LP and Healthcare Ventures Viii LP and Advent Management Iv Limited Partnership
    Transazioni
    • 23 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2010
    Consegnato il 13 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,650,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee and each of the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Nominees Limited as Security Agent for Advent Private Equity Fund Iv LP and Healthcare Ventures Viii LP and Getz Bros. & Co. (Bvi) Inc. and the National Endowment for Science and the Arts and Advent Management Iv Limited Partnership
    Transazioni
    • 13 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of variation of a debenture dated 2 december 2009
    Creato il 29 mar 2010
    Consegnato il 30 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,400,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Advent Private Equity Fund Iv LP Advent Management Iv Limited Partnership Healthcare Ventures Viii LP and the National Endowment for Science Technology and the Arts
    Transazioni
    • 30 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 dic 2009
    Consegnato il 08 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,150,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advent Private Equity Fund Iv LP Advent Management Iv Limited Partnership Healthcare Ventures Viii LP and the National Endowment for Science Technology and the Arts
    Transazioni
    • 08 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 apr 2006
    Consegnato il 28 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Finance Wales Investments (3) Limited
    Transazioni
    • 28 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 15 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CELLNOVO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 mar 2019Inizio dell'amministrazione
    31 mar 2021Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas John Edwards
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Praticante
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Graham Paul Bushby
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Praticante
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0