EPISTROPHE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEPISTROPHE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04358049
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EPISTROPHE LIMITED?

    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova EPISTROPHE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EPISTROPHE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VELOCIX LIMITED01 dic 200801 dic 2008
    CACHELOGIC LIMITED01 ago 200501 ago 2005
    SAVISO GROUP LIMITED22 gen 200222 gen 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di EPISTROPHE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per EPISTROPHE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 apr 2021

    9 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Cormac Vincent Whelan come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 More London Place London SE1 2AF a 1 More London Place London SE1 2AF in data 18 giu 2020

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF a 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol BS32 4UF

    2 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF

    2 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF

    2 pagineAD03

    Indirizzo della sede legale modificato da 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol BS32 4UF England a 1 More London Place London SE1 2AF in data 28 mag 2020

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF

    2 pagineAD02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 apr 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 apr 2020

    • Capitale: GBP 6.257568
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 16/03/2020
    RES13

    Nomina di Mr Scott Ashley Wallberg come amministratore in data 05 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ioli Tassopoulou come amministratore in data 05 feb 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 30 giu 2019

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Cormac Vincent Whelan come amministratore in data 23 set 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Trevor Dryden Foster come amministratore in data 23 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen John Vogelsang come amministratore in data 23 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di EPISTROPHE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOSTER, Trevor Dryden
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish219680750001
    WALLBERG, Scott Ashley
    3 Sheldon Square
    W2 6PY London
    Nokia
    England
    Amministratore
    3 Sheldon Square
    W2 6PY London
    Nokia
    England
    EnglandBritish266584090001
    AMESBURY, Bryan Mark
    54 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Segretario
    54 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    British67063580006
    HODGES, Debbie Carol
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    United Kingdom
    Segretario
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    United Kingdom
    British147575070001
    LEE, John
    36 Maids Causeway
    CB5 8DD Cambridge
    Segretario
    36 Maids Causeway
    CB5 8DD Cambridge
    British1975520002
    NICOLL, Amanda Jane
    Waterside Drive
    Aztec West
    BS32 4TR Bristol
    740
    United Kingdom
    Segretario
    Waterside Drive
    Aztec West
    BS32 4TR Bristol
    740
    United Kingdom
    180118940001
    ADRIANS INTERNATIONAL CONSULTANTS LIMITED
    4 Boys British School East Street
    CB10 1LH Saffron Walden
    Essex
    Segretario
    4 Boys British School East Street
    CB10 1LH Saffron Walden
    Essex
    41272030001
    AHMED, Tahir
    Blackberry Way
    Pont Prennau
    CF23 8FE Cardiff
    41
    South Glamorgan
    Amministratore
    Blackberry Way
    Pont Prennau
    CF23 8FE Cardiff
    41
    South Glamorgan
    WalesBritish103290510002
    AMESBURY, Bryan Mark
    54 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    54 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish67063580006
    CHAPMAN-PINCHER, Patricia
    Flat 7
    13-17 Long Lane
    EC1A 9PN London
    Amministratore
    Flat 7
    13-17 Long Lane
    EC1A 9PN London
    United KingdomBritish51618810005
    CORNWELL, Simon Anthony Vivian
    11 Eton Road
    NW3 4SS London
    Amministratore
    11 Eton Road
    NW3 4SS London
    EnglandBritish42636180001
    CUMMINGS, Andrew Peter
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish190614100001
    DODD, Stewart Michael
    Flat 2
    1 West Street
    WC2 London
    Amministratore
    Flat 2
    1 West Street
    WC2 London
    British54693380002
    FELISIAK, Nicholas Christopher
    Le Varclin
    Rue Le Varclin St Martin
    GY4 6AW Guernsey
    Amministratore
    Le Varclin
    Rue Le Varclin St Martin
    GY4 6AW Guernsey
    British96872740001
    FINLAY, Geoffrey John
    Magna Marbella 142
    Nugva Andalucia
    Marbella 29600
    Spain
    Amministratore
    Magna Marbella 142
    Nugva Andalucia
    Marbella 29600
    Spain
    British109242480001
    GALES, Benjamin John Francis
    121 Cambridge Science Park
    Milton Road
    CB4 0FZ Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    121 Cambridge Science Park
    Milton Road
    CB4 0FZ Cambridge
    Cambridgeshire
    British104596730001
    GARRETT, Laurence Roy
    30 Middle Street
    SG8 7RD Thriplow
    Cambridgeshire
    Amministratore
    30 Middle Street
    SG8 7RD Thriplow
    Cambridgeshire
    EnglandBritish84914060002
    GRAY, Stephen Douglas
    304 Splitrock Road
    03753 Grantham
    New Hampshire 03753
    Usa
    Amministratore
    304 Splitrock Road
    03753 Grantham
    New Hampshire 03753
    Usa
    Usa81459500001
    GREIG, Alasdair Douglas Michael
    The Thatched Cottage
    Church Road, Chrishall
    SG8 8QT Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Thatched Cottage
    Church Road, Chrishall
    SG8 8QT Royston
    Hertfordshire
    British91354490001
    HERRIOT, Walter John
    9 Shepreth Road
    Foxton
    CB2 6SU Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    9 Shepreth Road
    Foxton
    CB2 6SU Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish13213440001
    HILL, Stephen James
    Monks Well House
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Monks Well House
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    British68448760002
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    LARBEY, Paul Douglas
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritish267456560002
    LEE, John
    36 Maids Causeway
    CB5 8DD Cambridge
    Amministratore
    36 Maids Causeway
    CB5 8DD Cambridge
    EnglandBritish1975520002
    MCDONAGH, Rodney Lawrence
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Ely Road
    Milton
    CB24 6DD Cambridge
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritish157998600001
    MCKINNON, Alexander Wilson, Dr
    42 Redford Road
    EH13 0AE Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    42 Redford Road
    EH13 0AE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish105591010001
    NICOLL, Amanda Jane
    Stonehill Green
    Westlea
    SN5 7DJ Swindon
    The Quadrant
    Wiltshire
    England
    Amministratore
    Stonehill Green
    Westlea
    SN5 7DJ Swindon
    The Quadrant
    Wiltshire
    England
    EnglandBritish149770940001
    PARKER, Andrew James
    81 Parlour Close
    Histon
    CB4 9XR Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    81 Parlour Close
    Histon
    CB4 9XR Cambridge
    Cambridgeshire
    British80774620003
    ROBINSON, Phillip David
    Park House
    Queens Drive, Oxshott
    KT22 0PF Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Park House
    Queens Drive, Oxshott
    KT22 0PF Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish119843810001
    SADIQ, Liaqat Ali
    22 Shortwood Avenue
    TW18 4JL Staines
    Middlesex
    Amministratore
    22 Shortwood Avenue
    TW18 4JL Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish68493890001
    TASSOPOULOU, Ioli
    3 Sheldon Square
    W2 6PY London
    Nokia
    England
    Amministratore
    3 Sheldon Square
    W2 6PY London
    Nokia
    England
    EnglandGreek248719360001
    TWISS, Adam Dominic
    17 Citygate
    Woodhead Drive
    CB4 1YL Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 Citygate
    Woodhead Drive
    CB4 1YL Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish44597490005
    VOGELSANG, Stephen John
    1190 Beechwood Blvd
    Pittsburgh
    Pa 15206
    United States
    Amministratore
    1190 Beechwood Blvd
    Pittsburgh
    Pa 15206
    United States
    United StatesAmerican76903280001
    WHELAN, Cormac Vincent
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomIrish185706160001
    PAB NOMINEES LIMITED
    4 Boys British School
    East Street
    CB10 1LH Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    4 Boys British School
    East Street
    CB10 1LH Saffron Walden
    Essex
    65281790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EPISTROPHE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Nokia Oyj
    Karaportti 3
    PO BOX 22
    Espoo
    Nokia
    02610
    Finland
    03 ott 2017
    Karaportti 3
    PO BOX 22
    Espoo
    Nokia
    02610
    Finland
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Autorità legaleFinnish
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Waterside Drive, Aztec West
    Almondsbury
    BS32 4UF Bristol
    740
    England
    06 apr 2016
    Waterside Drive, Aztec West
    Almondsbury
    BS32 4UF Bristol
    740
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02650571
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EPISTROPHE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Extension letter
    Creato il 01 lug 2009
    Consegnato il 14 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) S.A.R.L
    Transazioni
    • 14 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2009
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Extension letter
    Creato il 01 lug 2009
    Consegnato il 04 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Amadeus Capital Partners Limited as Security Trustee (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 nov 2008
    Consegnato il 13 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) Sarl
    Transazioni
    • 13 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 nov 2008
    Consegnato il 02 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Amadeus Capital Partners Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2008
    Consegnato il 20 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) S.A.R.L.
    Transazioni
    • 20 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 giu 2007
    Consegnato il 15 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 15 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 giu 2006
    Consegnato il 14 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum from time to time in a deposit account the sum of £10,827.63.
    Persone aventi diritto
    • The Master Fellows and Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity within Thetown and University of Cambridge of King Henry T
    • The Master Fellows and Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity within Thehe Eighths Foundation
    Transazioni
    • 14 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 25 lug 2005
    Consegnato il 27 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The initial sum of £57,777.69 in a deposit account.
    Persone aventi diritto
    • The Master Fellows and Scholars Trinity College Cambridge
    Transazioni
    • 27 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 28 lug 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EPISTROPHE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 lug 2022Data di scioglimento
    24 apr 2020Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0