ELMSWAY (NO. 1) LIMITED

ELMSWAY (NO. 1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELMSWAY (NO. 1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04359815
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    • (7012) /
    • (7020) /
    • (7032) /

    Dove si trova ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o CHANTREY VELLACOTT DFK LLP
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITANNIC BUSINESS PARKS LIMITED10 set 200210 set 2002
    SOUTHTOUR LIMITED24 gen 200224 gen 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    23 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2012

    18 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Elmsway (No1) Limited Hercules Business Park Lostock Lane Lostock Bolton BL6 4BR England in data 02 giu 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 09 mag 2011

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da Canal Mill Botany Bay Villages Botany Brow Chorley Lancashire PR6 9AF in data 22 feb 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 gen 2011

    Stato del capitale al 26 gen 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 dic 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 gen 2010 al 30 gen 2010

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Timothy Knowles come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gerald Wood come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    4 pagineLQ01

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2009

    16 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 gen 2008

    16 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Segretario
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    DIXON, William Ronald
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    Amministratore
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    EnglandBritish136501510001
    HOPKINSON, Thomas Duncan
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish71862660002
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish141979130001
    ALLEN, Rachel Mary
    1263 Burnley Road
    Loveclough
    BB4 8RG Rossendale
    Lancashire
    Segretario
    1263 Burnley Road
    Loveclough
    BB4 8RG Rossendale
    Lancashire
    British98369110001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Segretario
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British85366800001
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Segretario
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    WESTHEAD, Paul
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    Segretario
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    British72955010002
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018560001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    EnglandBritish85366800001
    KNOWLES, Timothy John Peter
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Amministratore
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish33274370003
    WESTHEAD, Paul
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    British72955010002
    WOOD, Gerald Jospeh
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    Amministratore
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish110948700001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    ELMSWAY (NO. 1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security deed
    Creato il 12 set 2006
    Consegnato il 25 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 25 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 128 apr 2010Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
      • Numero di pratica 1
    Legal charge
    Creato il 09 mag 2003
    Consegnato il 17 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Brownlow business park tennyson street bolton. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 mag 2003
    Consegnato il 17 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Florence business park whalley new road blackburn. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 mag 2003
    Consegnato il 17 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Waverledge business park waverledge street great harwood blackburn. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2002
    Consegnato il 30 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second legal charge
    Creato il 09 lug 2002
    Consegnato il 25 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £25,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title number LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery of the company from time to time thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Southern Funding Limited
    Transazioni
    • 25 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 lug 2002
    Consegnato il 25 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant fixed plant and machinery of the company from time to time thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Property Finance Nominees (No 4) Limited
    Transazioni
    • 25 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 lug 2002
    Consegnato il 25 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Brownlow business park tennyson street bolton title number 502273, waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Property Finance Nominees (No 4) Limited
    Transazioni
    • 25 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 09 lug 2002
    Consegnato il 23 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/Hold property known as waterledge mill,great harwood,hyndburn,lancashire; la 36928;specific charge over all income and rights thereto and the proceeds of sale thereof,lease or other disposition and all deeds and documents thereto; all insurance and compensation monies; floating charge over all undertaking,property,assets and rights whatsoever; see form 395 for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 23 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 08 lug 2002
    Consegnato il 23 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 23 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ELMSWAY (NO. 1) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Murphy
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ricevitore amministrativo
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Bryn Williams
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ricevitore amministrativo
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    2
    DataTipo
    09 mag 2011Inizio della liquidazione
    16 ott 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Anthony Murphy
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Praticante
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Praticante
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0