ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED

ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04364710
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Regius Court, Penn
    High Wycombe
    HP10 8RL Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    legacy

    34 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2014

    Stato del capitale al 20 mag 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    23 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Cessazione della carica di David John Potter come amministratore in data 14 dic 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Geoffrey King il 20 giu 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Susan Elizabeth Jacquest il 20 giu 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kelly John Speller il 20 giu 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James Philip Bilsland il 20 giu 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Jeremy Lobatto il 20 giu 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Potter il 20 giu 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Nicholas James Philip Bilsland il 20 giu 2011

    3 pagineCH03

    Cessazione della carica di Fiona King come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Fiona King come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BILSLAND, Nicholas James Philip
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Uk
    Segretario
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Uk
    British66511970002
    BILSLAND, Nicholas James Philip
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66511970002
    JACQUEST, Susan Elizabeth
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish79924010004
    KING, Nicholas Geoffrey
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish96115160004
    LOBATTO, Paul Jeremy
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    EnglandBritish78687810002
    SPELLER, Kelly John
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish73635390001
    KING, Fiona Ann
    21 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Bucks
    Segretario
    21 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Bucks
    British80401500005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    KING, Fiona Ann
    21 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Bucks
    Amministratore
    21 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Bucks
    United KingdomBritish80401500005
    POTTER, David John
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    UkBritish135413030001
    ROWSELL, Richard William
    8 Winkfield Road
    SL4 4BG Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    8 Winkfield Road
    SL4 4BG Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish80260030002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ACQUEST DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Alderbourne st george's lane ascot t/no BK399582. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 2006
    Consegnato il 07 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    119-122 maybury road woking t/no's SY71912 SY520912 and SY521237. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2006
    Consegnato il 07 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of contract for purchase
    Creato il 11 gen 2006
    Consegnato il 17 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from nicholas king homes PLC to the chargee
    Brevi particolari
    All right title and interest in a contract dated 8 april 2004 for the purchase of the f/h property k/a fram penn road knotty green beaconsfield and the right to perform and to performance of the said contract and all rights and benefits in respect of the amounts receivable or accruing under the contract.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 17 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 nov 2003
    Consegnato il 13 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Hays barton, blackpond lane, farnham royal, buckinghamshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 27 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    45 altwood road, maidenhead, berkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 27 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured debenture
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating security the undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever including the uncalled capital of the company.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a orchard end fishery road bray maidenhead berkshire floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment on or used in or about the mortgaged property.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0