365 IT SUBCO NO.1 LIMITED
Panoramica
Nome della società | 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04366702 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Napoleon House Riseley Business Park, Basingstoke Road Riseley RG7 1NW Reading England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
5I LIMITED | 05 feb 2002 | 05 feb 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4 Cartel Business Centre Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW in data 10 apr 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Maclean come amministratore in data 22 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed 5I LIMITED\certificate issued on 01/12/11 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 30 giu 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Mb Secretaries Limited come segretario | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alastair Ferguson come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alastair Ferguson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Alastair William Ferguson come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Hearn come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Hearn come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alastair William Ferguson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 5 pagine | MG01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 12 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per David Gareth Hearn il 05 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Avenue SO17 1XF Southampton 11 Hampshire United Kingdom |
| 124285230001 | ||||||||||
ALLAN, Keith Andrew | Amministratore | 16 Sovereign Close CV8 1SQ Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Technical Director | 100161360001 | ||||||||
BROWN, Richard William | Amministratore | 24a Alma Road SL4 3HL Windsor Berkshire | England | British | Sales Director | 100161150001 | ||||||||
HOWELLS, Peter Hugh | Amministratore | Centurion House 11 Romans Field, RG7 2QH Silchester Berkshire | England | British | Director | 163030330001 | ||||||||
FERGUSON, Alastair William | Segretario | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | 154526830001 | |||||||||||
HEARN, David Gareth | Segretario | Middle Prospect New Road OX18 2LF Bampton Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 59462210001 | |||||||||
ORCHARD, Clive | Segretario | Birchtree Cottages Kings Road Silchester RG7 2NT Reading 2 Berkshire United Kingdom | British | Operations Director | 81052720003 | |||||||||
BOYES TURNER SECRETARIES LIMITED | Segretario | First Floor Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 74407280002 | |||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
FERGUSON, Alastair William | Amministratore | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 125179970001 | ||||||||
HEARN, David Gareth | Amministratore | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 59462210001 | ||||||||
MACLEAN, Peter | Amministratore | Steventon Manor RG25 3BE Steventon Hampshire | United Kingdom | British | Director | 157773140001 | ||||||||
ORCHARD, Clive | Amministratore | 47 Jubilee Close Pamber Heath RG26 3HP Tadley Hampshire | British | Operations Director | 81052720002 | |||||||||
RANSOM, Graham Richard | Amministratore | 8 Fairacre Woolton Hill RG20 9UF Newbury Berkshire | Uk | British | Company Director | 34690210001 | ||||||||
STEVENS, Terrence | Amministratore | 17 Elliott Rise SL5 8NN North Ascot Berkshire | British | Development Director | 81052700001 | |||||||||
BOYES TURNER DIRECTORS LIMITED | Amministratore | First Floor Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 101374610001 | |||||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
365 IT SUBCO NO.1 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 28 apr 2010 Consegnato il 29 apr 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account operated by field seymour parks as solicitors for the landlord under the lease pursuant to the terms of the said rent deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 30 nov 2007 Consegnato il 08 dic 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 set 2006 Consegnato il 19 set 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 08 mag 2006 Consegnato il 09 mag 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All monies from time to time standing to the credit of the interest-bearing deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 feb 2005 Consegnato il 22 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rental deposit deed | Creato il 08 apr 2004 Consegnato il 23 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account pursuant to the terms of the rental deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 17 lug 2002 Consegnato il 23 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £6,750.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum of £6,750.00. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0