PROPELLER BRANDS LIMITED

PROPELLER BRANDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROPELLER BRANDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04371975
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROPELLER BRANDS LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova PROPELLER BRANDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 14 Swanwick Shore
    Swanwick
    SO31 1ZL Southampton
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROPELLER BRANDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per PROPELLER BRANDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2022, non revisionato

    6 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2021, non revisionato

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Meridians Cross Second Floor, Grove House 6 Oceans Way Southampton SO14 3TJ United Kingdom a Unit 14 Swanwick Shore Swanwick Southampton SO31 1ZL in data 22 mar 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2020, non revisionato

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 14 the Boatyard Swanwick Marina Southampton SO31 1ZL England a Meridians Cross Second Floor, Grove House 6 Oceans Way Southampton SO14 3TJ in data 20 gen 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2019, non revisionato

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit L, Building 9 Swanwick Shore Swanwick Southampton SO31 1ZL England a Unit 14 the Boatyard Swanwick Marina Southampton SO31 1ZL in data 28 nov 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2018, non revisionato

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2017, non revisionato

    11 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 043719750007, creata il 21 feb 2017

    5 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 28 Oxford Street Southampton Hampshire SO14 3DJ a Unit L, Building 9 Swanwick Shore Swanwick Southampton SO31 1ZL in data 26 ott 2016

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di PROPELLER BRANDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WEEKS, Oliver Robert
    Swanwick Shore
    Swanwick
    SO31 1ZL Southampton
    Unit 14
    England
    Segretario
    Swanwick Shore
    Swanwick
    SO31 1ZL Southampton
    Unit 14
    England
    209226530001
    BOYLE, Matthew James
    1 Lukes Close
    Marina Drive Hamble
    SO31 4PH Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    1 Lukes Close
    Marina Drive Hamble
    SO31 4PH Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish39931180004
    DODD, Mark Jason
    59 St Catherines Road
    SO23 0PS Winchester
    Hampshire
    Segretario
    59 St Catherines Road
    SO23 0PS Winchester
    Hampshire
    British80745180003
    LIGHT, Karen Marie
    28 Oxford Street
    Southampton
    SO14 3DJ Hampshire
    Segretario
    28 Oxford Street
    Southampton
    SO14 3DJ Hampshire
    British129582370001
    WILES, Stephen Kenneth
    108 Brownhill Road
    Chandlers Ford
    SO53 2FL Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    108 Brownhill Road
    Chandlers Ford
    SO53 2FL Eastleigh
    Hampshire
    British89850780001
    DMCS SECRETARIES LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Segretario nominato
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900006030001
    DODD, Mark Jason
    59 St Catherines Road
    SO23 0PS Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    59 St Catherines Road
    SO23 0PS Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish80745180003
    DMCS DIRECTORS LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Amministratore delegato nominato
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900004430001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROPELLER BRANDS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Matthew James Boyle
    Swanwick Shore
    Swanwick
    SO31 1ZL Southampton
    Unit 14
    England
    06 apr 2016
    Swanwick Shore
    Swanwick
    SO31 1ZL Southampton
    Unit 14
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    PROPELLER BRANDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 feb 2017
    Consegnato il 02 mar 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22 february 2007 and
    Creato il 04 ott 2011
    Consegnato il 18 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 27 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 27 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 24 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H white star tavern, 28 oxford street, southampton, t/no hp 613683. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 apr 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    White star tavern 28 oxford street southampton t/no HP613683. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture creating fixed and floating charges
    Creato il 20 mar 2002
    Consegnato il 09 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0