SCISYS UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSCISYS UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04373530
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SCISYS UK LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Attività di gestione delle strutture informatiche (62030) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova SCISYS UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SCISYS UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SCISYS LIMITED04 mar 200204 mar 2002
    QUAYSHELFCO 903 LIMITED14 feb 200214 feb 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di SCISYS UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per SCISYS UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Darryl Eades il 10 ago 2022

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    34 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Previous capital reduction dated 17 december 2021 and filed at ch on 20 december 2021 in which the share cap of the company was reduced by cancelling the share premium account of £1,091,297 of the company in its entirety, did not take effect. The previous capital reduction dated 17 december 2021 and filed at ch on 20 decemeber 2021 in which the share cap of the company was reduced by cancelling and extinguishing 2,999,999 ord shares of £1 each in the capital of the company did take effect and the statement of capital of the company filed at ch on 20 december 2021 contunues to be correct. 31/05/2022
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    2 pagineSH20

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Stato del capitale al 20 dic 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    legacy

    pagineANNOTATION

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 17/12/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 17/12/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    pagineANNOTATION

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY England a 20 Fenchurch Street 14th Floor London EC3M 3BY in data 10 giu 2021

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Methuen Park Chippenham Wiltshire SN14 0GB a 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY in data 10 giu 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    36 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Darryl Eades come amministratore in data 23 ott 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Faris Mehdi Kadhim Mohammed come amministratore in data 23 ott 2020

    1 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Scisys Uk Ltd Methuen Park Chippenham Wiltshire SN14 0GB United Kingdom a 20 Fenchurch Street 14th Floor London EC3M 3BY

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di SCISYS UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANDRY MALTAIS, Sarah
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Segretario
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    265462140001
    BOULANGER, François
    Réné-Lévesque Blvd. W.
    25th Floor
    H3G 1T4 Montreal
    1350
    Quebec
    Canada
    Amministratore
    Réné-Lévesque Blvd. W.
    25th Floor
    H3G 1T4 Montreal
    1350
    Quebec
    Canada
    CanadaCanadian265463690001
    EADES, Darryl
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish276139200002
    MCGEEHAN, Tara, Ms.
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish242289410001
    TIMMS, Neil Geoffrey
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish254135300001
    BELMONT, David Gresford
    4 Glenview Close
    Nab Wood
    BD18 4AZ Shipley
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Glenview Close
    Nab Wood
    BD18 4AZ Shipley
    West Yorkshire
    British99897870001
    LAIRD, Natasha Louise
    Methuen Park
    SN14 0GB Chippenham
    No 2
    Wiltshire
    Segretario
    Methuen Park
    SN14 0GB Chippenham
    No 2
    Wiltshire
    218613020001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Segretario
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    British101309030001
    MURDEN, Martin Peter
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Segretario
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    British89690050001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Segretario nominato
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001160001
    AUBURN, John Harold Courtenay
    Kings Athelstans House
    36 Kingswall
    SN16 9BJ Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Kings Athelstans House
    36 Kingswall
    SN16 9BJ Malmesbury
    Wiltshire
    EnglandBritish86836420002
    BRIGNALL, Stephen
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Amministratore
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    United KingdomBritish116089640001
    CHEETHAM, Christopher Andrew
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Amministratore
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    EnglandBritish78076620006
    COGGER, Peter Andrew
    2 Ferndale Close
    Almondsbury
    BS32 4NU Bristol
    South Gloucestershire
    Amministratore
    2 Ferndale Close
    Almondsbury
    BS32 4NU Bristol
    South Gloucestershire
    British59816630001
    GAWTHORPE, David
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Amministratore
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    United KingdomBritish226362640002
    HAMPSON, Simon Mark
    East Farm Barn
    159 Bath Road
    SN12 8JR Atworth
    Wiltshire
    Amministratore
    East Farm Barn
    159 Bath Road
    SN12 8JR Atworth
    Wiltshire
    British87042590001
    HAYNES, John Balfour, Dr
    Steep Oakridge Lane
    Winscombe
    BS25 1LZ Somerset
    Avon
    Amministratore
    Steep Oakridge Lane
    Winscombe
    BS25 1LZ Somerset
    Avon
    EnglandBritish200888890001
    HILL, Stephen George
    47 Maes Y Sarn
    Pentyrch
    CF15 9QQ Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    47 Maes Y Sarn
    Pentyrch
    CF15 9QQ Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish112162780001
    HUCKER, Bryan Herbert
    Northlew
    Lansdowne Road
    BA1 5TD Bath
    Bnes
    Amministratore
    Northlew
    Lansdowne Road
    BA1 5TD Bath
    Bnes
    EnglandBritish7560560005
    JONES, David Rodney
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Amministratore
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    WalesBritish69172140002
    LOVE, Michael David, Dr
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Amministratore
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    United KingdomEnglish7560570001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Amministratore
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    United KingdomBritish101309030001
    MOHAMMED, Faris Mehdi Kadhim
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish67645590001
    SMITH, Adrian Trevor
    36 The Willows
    Highworth
    SN6 7PG Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    36 The Willows
    Highworth
    SN6 7PG Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish44525580002
    STEINSBERG, Graham Lawrence
    Bakers Close
    104 Lower Radley
    OX14 3BA Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bakers Close
    104 Lower Radley
    OX14 3BA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish34515710002
    NQH LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Amministratore delegato nominato
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001150001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SCISYS UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Scisys Uk Holding Ltd
    Methuen Park
    SN14 0GB Chippenham
    2 Methuen Park
    England
    06 apr 2016
    Methuen Park
    SN14 0GB Chippenham
    2 Methuen Park
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Cardiff
    Numero di registrazione3426416
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SCISYS UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2016
    Consegnato il 02 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lesmoir-Gordon, Boyle & Co. Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 set 2007
    Consegnato il 02 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    23 clothier road brislington bristol t/n BL60983,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 set 2007
    Consegnato il 18 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0