HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED

HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04386957
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hotwork Combustion Technology Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    West Yorkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    READCO 328 LIMITED05 mar 200205 mar 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 dic 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Sterling Bloom Holdings Limited come persona con controllo significativo il 08 feb 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Sterling Thermal Technology South Building Brunel Road Rabans Lane Industrial Area Aylesbury Buckinghamshire HP19 8TD England a Hotwork Combustion Technology Bretton Street Savile Town Dewsbury West Yorkshire WF12 9DB in data 26 feb 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Paver come amministratore in data 31 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Kathryn Elizabeth Tackley come segretario in data 31 gen 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Paver come segretario in data 31 gen 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Denis Hunzinger come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Sterling Bloom Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2017

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sterling Industries Plc Sterling House Brunel Road Aylesbury Buckinghamshire HP19 8SS a Sterling Thermal Technology South Building Brunel Road Rabans Lane Industrial Area Aylesbury Buckinghamshire HP19 8TD in data 03 ago 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    25 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TACKLEY, Kathryn Elizabeth
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    242817520001
    BOYCE, David Walter
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    United StatesAmericanManager190611570001
    MILLS, Robert Peter
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Bretton Street
    Savile Town
    WF12 9DB Dewsbury
    Hotwork Combustion Technology
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishManager199582930001
    BLUNN, David Howard
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    Segretario
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    British171553420001
    CROWTHER, Brian
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    BritishGeneral Manager81627250001
    CROWTHER, Patricia
    Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    14
    West Yorkshire
    Segretario
    Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    14
    West Yorkshire
    British151380250001
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British900012370001
    PAVER, Michael
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    Segretario
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    182924880001
    ROBINSON, Carol
    Rosedale Avenue
    WF2 6EP Wakefield
    17
    West Yorkshire
    Segretario
    Rosedale Avenue
    WF2 6EP Wakefield
    17
    West Yorkshire
    British151380300001
    ARMITAGE, Christopher Robert
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    Amministratore
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    United KingdomBritishCompany Director62637840002
    BLUNN, David Howard
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    Amministratore
    George Smith Way
    BA22 8QR Yeovil
    D L Group Building
    Somerset
    England
    EnglandBritishChartered Accountant160982330001
    BOND, Julian
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    Amministratore
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    United KingdomBritishSolicitor44995320003
    CROWTHER, Brian
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    14 Nell Gap Lane
    Middlestown
    WF4 4PH Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishGeneral Manager81627250001
    HUNZINGER, Denis
    Main Street
    Little Ouseburn
    YO26 9TG York
    Barley Cottage 1 Mount Pleasant
    North Yorkshire
    Amministratore
    Main Street
    Little Ouseburn
    YO26 9TG York
    Barley Cottage 1 Mount Pleasant
    North Yorkshire
    UkBritishSales Director151379980001
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British900012370001
    PAVER, Michael
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Brunel Road
    Rabans Lane Industrial Area
    HP19 8TD Aylesbury
    Sterling Thermal Technology South Building
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishFinancial Director10035580002
    ROBINSON, David
    17 Rosedale Avenue
    Sandal
    WF2 6EP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Rosedale Avenue
    Sandal
    WF2 6EP Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishEngineer81627450001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bloom Engineering Holdings Limited
    15 London End
    HP9 2HN Beaconsfield
    Kings Head House
    England
    06 apr 2016
    15 London End
    HP9 2HN Beaconsfield
    Kings Head House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione9777995
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HOTWORK COMBUSTION TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 feb 2007
    Consegnato il 08 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 06 lug 2006
    Consegnato il 26 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Partnership Investment Small Loans Fund L.P.
    Transazioni
    • 26 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 14 ott 2004
    Consegnato il 19 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account desination 45602387 with the bank and any deposit or account of any other currency.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposits
    Creato il 06 mar 2003
    Consegnato il 12 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A first fixed charge over any sums deposited or to be deposited by the company in any deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 12 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 apr 2002
    Consegnato il 30 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    (1) the deferred consideration due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the chargeand (2) £250,000 due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dyson Hotwork Limited
    Transazioni
    • 30 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0