LINDEN NEW HOMES LIMITED

LINDEN NEW HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLINDEN NEW HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04391802
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PITCOMP 281 LIMITED11 mar 200211 mar 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Cowley Business Park Cowley Uxbridge Middlesex UB8 2AL in data 20 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mar 2012

    Stato del capitale al 07 mar 2012

    • Capitale: GBP 2,500,000
    SH01

    Cessazione della carica di Ian Baker come amministratore in data 31 gen 2012

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul David Cooper il 28 feb 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Dylan May il 28 feb 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Baker il 28 feb 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di David Tilman come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Money come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOPER, Paul David
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    Amministratore
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72568660003
    MAY, Dylan
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    Amministratore
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    EnglandBritish140361960001
    AMATO, Sylvano
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    Segretario
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    British83551050001
    MONEY, Paul David
    10 Belsize Avenue
    Ealing
    W13 9TF London
    Segretario
    10 Belsize Avenue
    Ealing
    W13 9TF London
    British123128360001
    MORRISSEY, Brendan Jacob
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    Segretario
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    British73880040001
    STONE, Zillah Wendy
    34 Meadow Road
    SW19 2ND London
    Segretario
    34 Meadow Road
    SW19 2ND London
    British55643660001
    PITSEC LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Segretario
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    38734010001
    AMATO, Silvano
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritish156018520002
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Amministratore
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    BAKER, Ian
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish104527410004
    COATES, Christopher
    Chiltern House
    Maltmans Lane
    SL9 8RS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Chiltern House
    Maltmans Lane
    SL9 8RS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish46902170003
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DAVIES, Philip James
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    Amministratore
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    EnglandBritish115123570001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    MORRISSEY, Brendan Jacob
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    Amministratore
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    British73880040001
    PETTIFOR, Mark Andrew
    6 Woodside Close
    CR3 6AU Caterham
    Surrey
    Amministratore
    6 Woodside Close
    CR3 6AU Caterham
    Surrey
    EnglandBritish76909360002
    PRICE, Gerard Colquhoun
    Columbus
    Byfleet Road
    KT11 1EE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Columbus
    Byfleet Road
    KT11 1EE Cobham
    Surrey
    British82069070003
    TILMAN, David Ward
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish81215590001
    CASTLE NOTORNIS LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Amministratore
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    39348570001

    LINDEN NEW HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 28 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    584 wells road whitchurch t/no BL91718,the enterprise bedminster t/no AV224682,sheepway portishead (moor farm portbury common portishead) t/no ST251735,dover court t/no AV11059 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2004
    Consegnato il 30 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("Security Trustee")
    Transazioni
    • 30 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as holmethorpe redhill t/n SY694231 & t/n SY613043. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 feb 2004
    Consegnato il 05 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property at park road timperley altrincham t/n GM597073. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itself Andthe Finance Parties
    Transazioni
    • 05 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 gen 2004
    Consegnato il 31 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property at walnut tree close, guildford t/nos SY702678, SY490054, SY494683 and SY455384 and the unregistered land shown hatched black on plan b annexed to the charge as the property is shown outlined in red on plan a annexed to the charge.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itself Andthe Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 2003
    Consegnato il 09 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold property at park road timperley altrincham t/n GM94759.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 2003
    Consegnato il 08 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at park road, timperley, trafford.
    Persone aventi diritto
    • Countryside Residential (North West) Limited
    Transazioni
    • 08 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over beneficial interest
    Creato il 04 giu 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from linden homes north west limited to the chargee
    Brevi particolari
    Beneficial interest in the f/h properties k/a 36 and 38 alexandra road south whalley range t/nos LA5234 and GM857451 and 398 and 400 wilmslow road withington manchester t/no LA339156 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge by way of mortgage
    Creato il 13 gen 2003
    Consegnato il 21 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,594,700 and interest thereon due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All that freehold property known as land at metropolitan station approach and 129 rickmansworth road watford being the whole of the land comprised within title numbers HD374400 HD333992 and HD383608 and part of the land registered under title number HD371107 and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon.
    Persone aventi diritto
    • London Underground Limited
    Transazioni
    • 21 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2003
    Consegnato il 15 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at metropolitan station approach watford t/n HD371107 HD374400 HD333992 and HD383608.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 lug 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itself Andeach of the Lenders (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 lug 2002
    Consegnato il 08 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as former bt side filton road horfield bristol; t/nos BL53409 and BL66225.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LINDEN NEW HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Leslie Smith
    Mercer & Hole 72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Praticante
    Mercer & Hole 72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Peter John Godfrey-Evans
    Mercer & Hole
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Praticante
    Mercer & Hole
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0