GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED

GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGOLDERS MANOR ESTATES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04392918
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Castlegate House 36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al12 mar 2020
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma26 mar 2020
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al12 mar 2019
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    21 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    21 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    13 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    14 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    16 pagineWU07

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Goldwins 75 Maygrove Road London NW6 2EG a Castlegate House 36 Castle Street Hertford Hertfordshire SG14 1HH in data 02 gen 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore

    3 pagineWU04

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Iscrizione dell'ipoteca 043929180020, creata il 01 lug 2019

    4 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mar 2016

    Stato del capitale al 23 mar 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2015

    Stato del capitale al 17 mar 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mar 2014

    Stato del capitale al 21 mar 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Chi sono gli amministratori di GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROSZ, Mireille Bella
    Golders Manor Drive
    NW11 9HU London
    9
    Segretario
    Golders Manor Drive
    NW11 9HU London
    9
    British50824180001
    GROSZ, Samuel Benjamin
    9 Golders Manor Drive
    NW11 9HU London
    Amministratore
    9 Golders Manor Drive
    NW11 9HU London
    EnglandBritishDirector155093070001
    HUS, Chaim
    23 Ravensdale Road
    N16 6TJ London
    Segretario
    23 Ravensdale Road
    N16 6TJ London
    Belgian125327070001
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Segretario nominato
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    GROSZ, Mireille Bella
    Golders Manor Drive
    NW11 9HU London
    9
    Amministratore
    Golders Manor Drive
    NW11 9HU London
    9
    EnglandBritishCo Director50824180001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Amministratore delegato nominato
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Samuel Benjamin Grosz
    Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House 36
    Hertfordshire
    12 mar 2017
    Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House 36
    Hertfordshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 lug 2019
    Consegnato il 08 lug 2019
    In corso
    Breve descrizione
    Flat 1 eden court mansions. 28 grove road. Bournemouth BH1 3AZ.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Benjamin Grosz and Mirelle Grosz
    Transazioni
    • 08 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 2009
    Consegnato il 13 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    105 frobisher road hornsey london t/no:NGL109949 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 01 mag 2009
    Consegnato il 13 mag 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge of a registered estate
    Creato il 27 mag 2008
    Consegnato il 05 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    200,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    105 frobisher road london t/no. NGL109949.
    Persone aventi diritto
    • Epiclease Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 20 feb 2008
    Consegnato il 26 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge other property at any time hereinafter vested in the company all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests and it's book debts.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 2008
    Consegnato il 26 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    97 frobisher road london t/n NGL384365.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 218 mag 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 207 nov 2012Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
    • 207 nov 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 205 feb 2013Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 2
    Legal charge
    Creato il 20 feb 2008
    Consegnato il 26 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    95 frobishier road road london t/n MX379189.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 118 mag 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 107 nov 2012Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
    • 107 nov 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 105 feb 2013Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 1
    Legal charge
    Creato il 20 feb 2008
    Consegnato il 26 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    98 thorpedale road london t/n LN165772.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 318 mag 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 307 nov 2012Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
    • 307 nov 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 305 feb 2013Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 3
    Legal charge
    Creato il 18 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 1 eden court mansions grove road east cliff bournemouth dorset and garage.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 ott 2007
    Consegnato il 10 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 set 2006
    Consegnato il 16 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 14 ott 2005
    Consegnato il 18 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 105 frobisher road london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 2005
    Consegnato il 21 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 97 frobisher road london t/no NGL384365.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 2005
    Consegnato il 21 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 95 frobisher road london t/no MX379189.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 2005
    Consegnato il 29 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 98 thorpedale road london LN165772.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 2002
    Consegnato il 07 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 95-97 frobisher road london N8 oqu t/nos: MX379189 and NGL384365. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2002
    Consegnato il 07 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a 98 thorpedale road london N4 3BS t/no LN165772. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2002
    Consegnato il 07 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 2002
    Consegnato il 19 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as 82 archway rd,upper holloway,london N19; t/no ngl 317828. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2002
    Consegnato il 10 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as 82 archway road upper holloway london N19 t/no;-NGL317828. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GOLDERS MANOR ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Ricevitore/gestore
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Ricevitore/gestore
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    London
    Ricevitore/gestore
    88 Wood Street
    London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Ricevitore/gestore
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Ricevitore/gestore
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    London
    Ricevitore/gestore
    88 Wood Street
    London
    3Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Ricevitore/gestore
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Ricevitore/gestore
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    London
    Ricevitore/gestore
    88 Wood Street
    London
    4
    DataTipo
    21 mar 2019Data della petizione
    19 giu 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nigel Heath Sinclair
    Castlegate House 36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    Praticante
    Castlegate House 36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0