OMNITURE

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOMNITURE
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 04395864
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OMNITURE?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova OMNITURE?

    Indirizzo della sede legale
    5 New Street Square
    EC4A 3TW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OMNITURE?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OMNITURE LIMITED01 ott 200701 ott 2007
    TOUCH CLARITY LIMITED05 lug 200205 lug 2002
    PINCO 1744 LIMITED15 mar 200215 mar 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di OMNITURE?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per OMNITURE?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Stephan Van Herck come amministratore in data 24 set 2012

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Nomina di Barry Keith Slivinsky come amministratore in data 24 apr 2012

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mag 2012

    Stato del capitale al 02 mag 2012

    • Capitale: GBP 610.437
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Van Herck il 29 mar 2012

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Richard Thomas Rowley come amministratore in data 19 apr 2012

    1 pagineTM01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reregistration from private LIMITED to private UNLIMITED 29/02/2012
    RES13

    Assenso alla riregistrazione

    1 pagineFOA-RR

    Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato

    1 pagineCERT3

    Riregistrazione da società a responsabilità limitata privata a società a responsabilità illimitata privata

    2 pagineRR05

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    25 pagineMAR

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    20 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    31 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 30 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    22 pagineAA

    Nomina di Stephan Van Herck come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Weston come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    27/01/2010
    RES13

    Nomina di Joseph James Nemeth Jr come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Richard Thomas Rowley come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di OMNITURE?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    Segretario
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    84071220002
    NEMETH JR, Joseph James
    345 Park Avenue
    San Jose
    95110
    Caligornia
    Amministratore
    345 Park Avenue
    San Jose
    95110
    Caligornia
    UsaAmerican127487240001
    SLIVINSKY, Barry Keith
    Park Avenue
    San Jose
    345
    California 95110
    Usa
    Amministratore
    Park Avenue
    San Jose
    345
    California 95110
    Usa
    UsaAmerican168754990001
    PHILLIPS, Alan Paul Rolleston
    3 The Bothy
    16 Croughton Road Aynho
    OX17 3BA Banbury
    Oxfordshire
    Segretario
    3 The Bothy
    16 Croughton Road Aynho
    OX17 3BA Banbury
    Oxfordshire
    British4759980001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BOWDEN, Laurel Charmaine
    25 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Amministratore
    25 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    EnglandBritish69302320002
    BROWN, Timothy James
    64 Magnolia Road
    Chiswick
    W4 3QZ London
    Amministratore
    64 Magnolia Road
    Chiswick
    W4 3QZ London
    British76514120005
    HARDIE, Charles Jeremy Mawdesley
    13 Ainger Road
    Primrose Hill
    NW3 3AT London
    Amministratore
    13 Ainger Road
    Primrose Hill
    NW3 3AT London
    British35570070004
    HERRING, Michael
    4896 Last Stand Drive
    84098 Park City
    Utah 84098
    Usa
    Amministratore
    4896 Last Stand Drive
    84098 Park City
    Utah 84098
    Usa
    American106112350001
    HODGKINSON, Marcus Stefan
    Fairmile
    Silwood Close
    SL5 7DX Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Fairmile
    Silwood Close
    SL5 7DX Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish78883220001
    JAMES, Joshua G
    4223 Vintage Circle
    Provo
    Utah Ut 84604
    Usa
    Amministratore
    4223 Vintage Circle
    Provo
    Utah Ut 84604
    Usa
    American121256690001
    KELLEHER, Alexander
    18 Marloes Road
    W8 5LH London
    Amministratore
    18 Marloes Road
    W8 5LH London
    British84024040001
    KELLIHER, Patrick Edward
    West Riverwalk Drive
    84065 Riverton
    971
    Utah
    Usa
    Amministratore
    West Riverwalk Drive
    84065 Riverton
    971
    Utah
    Usa
    American128599580001
    KOPANS, Haim
    6 Hazaz St.
    FOREIGN Rishon Le'Tzion
    Israel 75738
    Israel
    Amministratore
    6 Hazaz St.
    FOREIGN Rishon Le'Tzion
    Israel 75738
    Israel
    Israeli100855540001
    OTT, Alexander
    2122 Inverness Ln
    Berwyn
    Pa 19312
    Usa
    Amministratore
    2122 Inverness Ln
    Berwyn
    Pa 19312
    Usa
    German101981100001
    PHILLIPS, Alan Paul Rolleston
    3 The Bothy
    16 Croughton Road Aynho
    OX17 3BA Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    3 The Bothy
    16 Croughton Road Aynho
    OX17 3BA Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish4759980001
    RICHMOND, David Jeremy Norcross
    35 Oakhill Avenue
    HA5 3DL Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    35 Oakhill Avenue
    HA5 3DL Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish31352060001
    ROWLEY, Richard Thomas
    345 Park Avenue
    San Jose
    95110
    California
    Amministratore
    345 Park Avenue
    San Jose
    95110
    California
    UsaAmerican148550010001
    UPSTONE, Stephen Colin
    20c Harvist Road
    NW6 6SD London
    Amministratore
    20c Harvist Road
    NW6 6SD London
    British76143210001
    VAN HERCK, Stephan
    Market Street
    SL6 8AD Maidenhead
    34-38
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Market Street
    SL6 8AD Maidenhead
    34-38
    Berkshire
    United Kingdom
    BelgiumBelgian134425150001
    WESTON, Neil Mcclelland
    5 Bradstone Brook
    Christmas Hill
    GU4 8HE Shalford
    Surrey
    Amministratore
    5 Bradstone Brook
    Christmas Hill
    GU4 8HE Shalford
    Surrey
    British120147820001
    NEWMEDIA SPARK DIRECTORS LTD
    Lacon House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Amministratore
    Lacon House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    121327270001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    OMNITURE ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 nov 2006
    Consegnato il 24 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the noteholders or any of them
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jerusalem Venture Partners Iv L.P. as Security Trustee for the Noteholders (The "Securitytrustee")
    Transazioni
    • 24 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 30 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re: touch clarity limited, business premium account, account number 80182990. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 nov 2002
    Consegnato il 25 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 mag 2002
    Consegnato il 04 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Deferred consideration of £100,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Touch Clarity Limited (In Administration)
    Transazioni
    • 04 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0