RENEW LEEDS LIMITED

RENEW LEEDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRENEW LEEDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 04395986
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RENEW LEEDS LIMITED?

    • Altre attività di servizi di informazione n.c.a. (63990) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di assistenza sociale senza alloggio n.c.a. (88990) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova RENEW LEEDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RENEW LEEDS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEEDS PARTNERSHIP CHARITABLE HOMES LIMITED15 mar 200215 mar 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di RENEW LEEDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per RENEW LEEDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 30 set 2016

    31 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2016 al 29 set 2016

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Moore and Smalley Llp Richard House Winckley Square Preston Lancashire PR1 3HP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Moore and Smalley Llp Richard House Winckley Square Preston Lancashire PR1 3HP

    1 pagineAD02

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2016 al 30 set 2016

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Osmondthorpe Community, Education & Learning Centr Osmondthorpe Lane Leeds LS9 9EG England a Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre Osmondthorpe Lane Leeds LS9 9EG in data 23 giu 2016

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 34 Regent Street Leeds West Yorkshire LS2 7QN a Osmondthorpe Community, Education & Learning Centr Osmondthorpe Lane Leeds LS9 9EG in data 22 giu 2016

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 043959860003 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 043959860004 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    7 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    29 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Christopher Huw Jones come segretario in data 15 dic 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Hilary Jane Waite come amministratore in data 15 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Harold Kenyon come amministratore in data 15 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ali Akbor come amministratore in data 15 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ali Akbor come segretario in data 15 dic 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015

    25 pagineAA

    Nomina di Mr Asghar Khan come amministratore in data 24 apr 2015

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 043959860004, creata il 10 mar 2015

    25 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di RENEW LEEDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Christopher Huw
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    Segretario
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    204412990001
    BILLINGTON, Christopher Mark
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    Amministratore
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    United KingdomBritishSolicitor182289180001
    HEATH, Margaret Elizabeth
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    Amministratore
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    EnglandBritishMentor Manager71553380005
    JONES, Christopher Huw
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Manager153907120002
    KHAN, Asghar
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    Amministratore
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    EnglandBritishLocal Councillor197234990001
    MCLOUGHLIN, Kellie Jayne
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    Amministratore
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    EnglandBritishMarketing Manager181959920001
    ROSS, William Lindsay
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    Amministratore
    Osmondthorpe Lane
    LS9 9EG Leeds
    Osmondthorpe Community,Education & Learning Centre
    England
    EnglandBritishConsultant24248420002
    TAYLOR, Andrew
    Kings Mount
    LS17 5NS Leeds
    30
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kings Mount
    LS17 5NS Leeds
    30
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHousing And Regeneration Consultant91916310001
    AKBOR, Ali
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    Segretario
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    169067750001
    BEAUMONT, Joanne Alison
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    Segretario
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    British149461020001
    BRIERLEY, Jennifer Mary
    22 New Walk Terrace
    Fulford Road
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    Segretario
    22 New Walk Terrace
    Fulford Road
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    BritishHousing Association Chief Exe36659180001
    WALKER, Matthew Alan
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    Segretario
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    169080100001
    WILLIAMSON, Stephen John
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    Segretario
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    Other10075720003
    AKBOR, Ali
    2 Hampton Street
    OL8 1RF Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    2 Hampton Street
    OL8 1RF Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishChief Executive66862580001
    ALI, Ansar
    69 Holly Park Drive
    BD7 4BY Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    69 Holly Park Drive
    BD7 4BY Bradford
    West Yorkshire
    United KingdomBritishHousing73024450002
    ATKINSON, Peter James
    1 Granary Court
    Heslington
    YO10 5JU York
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Granary Court
    Heslington
    YO10 5JU York
    North Yorkshire
    BritishSurveyor85183380001
    BOWDEN, Tonia Sharon
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Teacher156644410001
    BRIERLEY, Jennifer Mary
    22 New Walk Terrace
    Fulford Road
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    22 New Walk Terrace
    Fulford Road
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishHousing Association Chief Exe36659180001
    CARTER, John Leslie
    25 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    25 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCo Director2015190002
    CLOSE, Stephen Roy
    14 Barnswick Close
    WF8 3QU Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    14 Barnswick Close
    WF8 3QU Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive10075640001
    COOPER, Darren Ian
    17 Dale Park Close
    Cookridge
    LS16 7PR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Dale Park Close
    Cookridge
    LS16 7PR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director117523860001
    COUPLAND, Mark
    Harvest House
    Main Street Upton
    DN22 0RA Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Harvest House
    Main Street Upton
    DN22 0RA Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritishHousing Manager126565640001
    GAMBLE, Andrew John
    4 Hunger Hills Avenue
    LS18 5JT Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Hunger Hills Avenue
    LS18 5JT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDevelopment Director281068750001
    HUDSON, Alec
    7 Haighside Way
    Rothwell
    LS26 0UG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Haighside Way
    Rothwell
    LS26 0UG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCivil Servant5639280001
    KELLY-ALI, Helen
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    Amministratore
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritishCivil Servant170890470001
    KENYON, Robert Harold
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Street
    LS2 7QN Leeds
    34
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHealth Manager154176460003
    LEWIS, Richard Alwyn
    121 Roker Lane
    LS28 9NB Pudsey
    West Yorkshire
    Amministratore
    121 Roker Lane
    LS28 9NB Pudsey
    West Yorkshire
    BritishHousing Officer85183200001
    LOBLEY, Matthew Richard Dean
    Parkwood Court
    Roundhay
    LS8 1JV Leeds
    5
    West Yorkshire
    Amministratore
    Parkwood Court
    Roundhay
    LS8 1JV Leeds
    5
    West Yorkshire
    United KingdomBritishElected Councillor133175510001
    LORD, Christopher
    62 Curzon Terrace
    South Bank
    YO23 1HA York
    North Yorkshire
    Amministratore
    62 Curzon Terrace
    South Bank
    YO23 1HA York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishHousing Manager101662290001
    LUPTON, Helen Elizabeth
    Bailey Close Bland Hill
    Norwood
    HG3 1TE Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bailey Close Bland Hill
    Norwood
    HG3 1TE Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishRegional Manager72843770001
    MCRAE, Merran
    19 Brookfield Road
    Headingley
    LS6 4EJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    19 Brookfield Road
    Headingley
    LS6 4EJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishSocial Housing Ceo105507010001
    PARKAR, Nazir Ahmed
    22 Gledhow Park Avenue
    LS7 4JR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    22 Gledhow Park Avenue
    LS7 4JR Leeds
    West Yorkshire
    BritishPartnership Manager63972590001
    PEARSON, Stephen John
    High Ash Avenue
    LS17 6RX Leeds
    79
    West Yorkshire
    Amministratore
    High Ash Avenue
    LS17 6RX Leeds
    79
    West Yorkshire
    United KingdomBritishHousing Director42818060002
    TENNANT, Paul
    176 Saltergate Drive
    HG3 2XZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    176 Saltergate Drive
    HG3 2XZ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChief Executive Housing Associ71278800002
    TOLSON, David
    Farmer's Cottage
    Top O'Th' Lane, Brindle
    PR6 8PA Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Farmer's Cottage
    Top O'Th' Lane, Brindle
    PR6 8PA Chorley
    Lancashire
    BritishManagement Consultant112768670001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per RENEW LEEDS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    31 gen 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    RENEW LEEDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 mar 2015
    Consegnato il 31 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Unity Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 ott 2014
    Consegnato il 14 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H 2 killingbeck court leeds t/no.YY28456.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Unity Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Tenancy agreement
    Creato il 16 mag 2006
    Consegnato il 17 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £2,500.00 or any other amount for the time being standing to the credit of the rent deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Montgomery Property Investments Limited
    Transazioni
    • 17 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Tenancy agreement
    Creato il 12 set 2005
    Consegnato il 13 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £5,000.00 or any other amount for the time being standing to the credit of the rent deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Montgomery Property Investments Limited
    Transazioni
    • 13 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0