DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04401640 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TRUSTMARQUE ACQUISITIONS LIMITED | 04 apr 2002 | 04 apr 2002 |
| BROOMCO (2860) LIMITED | 22 mar 2002 | 22 mar 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 15 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 dic 2016 | 14 pagine | 4.68 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT a 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG in data 05 dic 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 044016400008 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 dic 2015
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor 100 Wood Street London EC2V 7AN a Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT in data 04 gen 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Martin John Trainer come amministratore in data 14 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Charles Mills come segretario in data 14 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Dermot James Joyce come amministratore in data 14 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed trustmarque acquisitions LIMITED\certificate issued on 11/12/15 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di James Christopher Michael Woolley come amministratore in data 03 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Neil Martin Simpson come amministratore in data 26 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Varie Section 519 | 2 pagine | MISC | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Dermot James Joyce il 11 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Charles Mills il 02 feb 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Christopher Michael Woolley il 02 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin John Trainer il 02 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Dermot James Joyce il 02 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSON, Paul John | Segretario | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | British | 84739280002 | ||||||
| GODLIMAN, Victoria | Segretario | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | 167818480001 | |||||||
| METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Segretario | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | British | 73646130001 | ||||||
| MILLS, Peter Charles | Segretario | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | 191202760001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BLOW, Bridget Penelope | Amministratore | Flat 119 B Central 38 Paradise Street B1 2AF Birmingham West Midlands | England | British | 115125670001 | |||||
| COOKE, Ursula | Amministratore | 70 Bootham YO30 7DF York | British | 115125770002 | ||||||
| FERGUSON, Paul John | Amministratore | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | England | British | 84739280002 | |||||
| FINLAYSON, David John Mcintosh | Amministratore | 8 Greenfields New Barn Lane Prestbury GL52 3LG Cheltenham Gloucestershire | British | 33124430005 | ||||||
| GODLIMAN, Victoria | Amministratore | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | England | British | 83684440003 | |||||
| HADDOW, Scott William | Amministratore | Chelford Road WA16 8LY Knutsford Spinney End Cheshire United Kingdom | England | British | 121651070002 | |||||
| JOYCE, Dermot James | Amministratore | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | Irish | 181301350001 | |||||
| LIGERTWOOD, Mark Murray | Amministratore | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Scotland | United Kingdom | Uk | 179214640001 | |||||
| LLOYD, Colin Thomas | Amministratore | Fawke Common Underriver TN15 0JX Sevenoaks Fawke House Kent | United Kingdom | British | 3616430001 | |||||
| METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Amministratore | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | United Kingdom | British | 73646130001 | |||||
| MILLER, Ross Charles | Amministratore | Primrose Farm Hagg Lane Dunnington YO19 5PE York Yorkshire | England | British | 84739210001 | |||||
| ROGERS, Christine Margaret | Amministratore | The Old Granary Chilton Road HP18 0DN Chearsley Buckinghamshire | United Kingdom | British | 66374680002 | |||||
| SIMPSON, Neil Martin | Amministratore | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | British | 183192810001 | |||||
| TRAINER, Martin John | Amministratore | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | 124180840001 | |||||
| WOOLLEY, James Christopher Michael | Amministratore | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | 156851530001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 17 dic 2014 Consegnato il 19 dic 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 17 lug 2013 Consegnato il 19 lug 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of trustmarque acquisitions limited.. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 07 giu 2013 Consegnato il 14 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 ago 2006 Consegnato il 18 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of securities | Creato il 12 ago 2006 Consegnato il 18 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Its whole right title and benefit of the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 25 giu 2002 Consegnato il 09 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 05 giu 2002 Consegnato il 11 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 05 apr 2002 Consegnato il 17 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0