ASTLEY FACADES LIMITED

ASTLEY FACADES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASTLEY FACADES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04404078
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASTLEY FACADES LIMITED?

    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova ASTLEY FACADES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bespoke Insolvency Solutions
    Suite 6 1-7 Taylor Street
    BL9 6DT Bury
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASTLEY FACADES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ASTLEY FACADES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    19 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Obs Recovery 106 Bradley House Radcliffe Moor Road Bolton BL2 6RT a Bespoke Insolvency Solutions Suite 6 1-7 Taylor Street Bury BL9 6DT in data 15 ago 2019

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Refresh Recovery Limited West Lancashire Investment Centre Maple View White Moss Business Park Skelmersdale Lancs WN8 9TG a C/O C/O 106 Bradley House Radcliffe Moor Road Bolton BL2 6RT in data 12 giu 2018

    4 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    33 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 19 Hurricane Court Hurricane Drive Liverpool International Business Park Liverpool L24 8RL England a West Lancashire Investment Centre Maple View White Moss Business Park Skelmersdale Lancs WN8 9TG in data 17 mar 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    20 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Cleveley Stables 458 Allerton Road Allerton Liverpool L18 9UU England a Unit 19 Hurricane Court Hurricane Drive Liverpool International Business Park Liverpool L24 8RL in data 21 dic 2016

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 044040780004, creata il 15 nov 2016

    10 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Shaun Maclean il 27 ott 2016

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Joseph Spencer Haworth come amministratore in data 27 ott 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Shaun Maclean come amministratore in data 27 ott 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Martin David Holmes come amministratore in data 27 ott 2016

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Bow Chambers Tib Lane Manchester M2 4JB England a Cleveley Stables 458 Allerton Road Allerton Liverpool L18 9UU in data 01 nov 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015

    32 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Corless come amministratore in data 19 lug 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ASTLEY FACADES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOLMES, Martin David
    South Drive
    HG2 8AT Harrogate
    29
    England
    Amministratore
    South Drive
    HG2 8AT Harrogate
    29
    England
    EnglandBritish110010090001
    MACLEAN, Shaun
    458 Allerton Road
    Allerton
    L18 9UU Liverpool
    Cleveley Stables
    England
    Amministratore
    458 Allerton Road
    Allerton
    L18 9UU Liverpool
    Cleveley Stables
    England
    EnglandBritish209161090002
    AVERY, Stephen John
    32c Kenilworth Road
    FK9 4EH Bridge Of Allan
    Stirling
    Segretario
    32c Kenilworth Road
    FK9 4EH Bridge Of Allan
    Stirling
    British73550410001
    WALKER, Simon
    2 Emperor Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XR Sunderland
    Emperor House
    England
    Segretario
    2 Emperor Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XR Sunderland
    Emperor House
    England
    172705690001
    ARGUS NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    Segretario nominato
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    900010830001
    AVERY, Stephen John
    32c Kenilworth Road
    FK9 4EH Bridge Of Allan
    Stirling
    Amministratore
    32c Kenilworth Road
    FK9 4EH Bridge Of Allan
    Stirling
    United KingdomBritish73550410001
    BILLINGS, Barrington Everton Glendon
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    Amministratore
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    United KingdomBritish72533660002
    CORLESS, Andrew
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    Amministratore
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    EnglandBritish167835180001
    CRAWFORD, Michael
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    Amministratore
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    EnglandBritish193244910001
    DAVIS, Mark Timothy
    2 Emperor Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XR Sunderland
    Emperor House
    England
    Amministratore
    2 Emperor Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XR Sunderland
    Emperor House
    England
    EnglandBritish172695370001
    HAWORTH, Joseph Spencer
    458 Allerton Road
    Allerton
    L18 9UU Liverpool
    Cleveley Stables
    England
    Amministratore
    458 Allerton Road
    Allerton
    L18 9UU Liverpool
    Cleveley Stables
    England
    EnglandBritish172093000001
    LAWRENCE, Ian Roy
    Holly Farm
    Chapel Lane
    WA8 4NX Cronton
    Widnes
    Amministratore
    Holly Farm
    Chapel Lane
    WA8 4NX Cronton
    Widnes
    United KingdomBritish81666850003
    MCQUEEN, Frederick George
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    Amministratore
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    EnglandBritish88418840001
    SELF, Ian
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    Amministratore
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    EnglandBritish93172800001
    THOMPSON, Allan
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    Amministratore
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    United KingdomBritish193620580001
    WALKER, John Robert
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    Amministratore
    Tib Lane
    M2 4JB Manchester
    Bow Chambers
    England
    EnglandBritish175674710001
    ARGUS NOMINEE DIRECTORS LIMITED
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    Amministratore delegato nominato
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    900010820001

    ASTLEY FACADES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 nov 2016
    Consegnato il 21 nov 2016
    In corso
    Breve descrizione
    This is an accession deed pursuant to a debenture dated 15 november 2016 between, inter alia, duality group limited and shaun maclean.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Shaun Maclean
    Transazioni
    • 21 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 giu 2014
    Consegnato il 17 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2011
    Consegnato il 29 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 lug 2002
    Consegnato il 17 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    ASTLEY FACADES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 mar 2017Inizio dell'amministrazione
    27 feb 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter John Harold
    West Lancashire Investment Centre Maple View
    White Moss Business Park
    WN8 9TG Skelmersdale
    Lancashire
    Praticante
    West Lancashire Investment Centre Maple View
    White Moss Business Park
    WN8 9TG Skelmersdale
    Lancashire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0