LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED
Panoramica
Nome della società | LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04405441 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1-3 Strand London WC2N 5EH |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LGPS NOMINEE (STOCKLEY PARK) LIMITED | 27 mar 2002 | 27 mar 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Donald Uriah Simpson come amministratore in data 20 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alice Morgan come segretario in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Megan Barnes come segretario in data 30 nov 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Alice Morgan come segretario in data 08 mar 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Heather Maria Rayner come segretario in data 08 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per John Flynn il 09 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Howard Mcgillicuddy come amministratore in data 30 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per John Flynn il 26 ago 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Howard Mcgillicuddy il 01 mag 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNES, Megan | Segretario | 1-3 Strand London WC2N 5EH | 253071560001 | |||||||
FLYNN, John | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | Scotland | British | Company Director | 163832130003 | ||||
WHITEHOUSE, Robert John | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | England | British | Retired | 131962420001 | ||||
BAKER, Helen Alice | Segretario | 28 Silverstone Close RH1 2HQ Redhill Surrey | British | 108742050002 | ||||||
COCKBURN, Emma Suzanne | Segretario | Redhill Cottage Redhill, Wateringbury ME18 5LA Maidstone Kent | British | 125280550001 | ||||||
DURRANT, Andrew Peter | Segretario | 340 Sidegate Lane IP4 3DW Ipswich Suffolk | British | 85381310004 | ||||||
EVES, Richard Anthony | Segretario | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
FORWARD, David Charles | Segretario | 1-3 Strand London WC2N 5EH | 158850440001 | |||||||
HIGGINS, Philip Lyndon | Segretario | Strand WC2N 5EH London 1-3 | British | 134189400001 | ||||||
MORGAN, Alice | Segretario | 1-3 Strand London WC2N 5EH | British | 205629290001 | ||||||
NOBLE, Mark David | Segretario | 1-3 Strand London WC2N 5EH | British | 125124050001 | ||||||
POOLE, Andrew Philip | Segretario | Flat 28 2 Lansdowne Drive E8 3EZ London | British | 90354630001 | ||||||
RAYNER, Heather Maria | Segretario | 1-3 Strand London WC2N 5EH | 156535570001 | |||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
BOREHAM, Peter John | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 120055890001 | ||||
BOWERS, David | Amministratore | 11 The Pennings Aylesbury Road HP22 6JE Wendover Buckinghamshire | British | Chief Accountant | 59303950002 | |||||
COOPER, Malcolm Charles | Amministratore | 5 Dukes Avenue Finchley N3 2DE London | England | British | Treasurer | 67587540001 | ||||
DUFFY, Dennis James | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | British | Chartered Engineer | 95052600001 | |||||
EDWARDS, Stanley Christopher | Amministratore | 104 Cranham Gardens Cranham RM14 1JN Upminster Essex | British | Retired | 95286540001 | |||||
FOSTER, Alan Peter | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | United Kingdom | British | Accountant | 130915810001 | ||||
MATTHEWS, Terence Ronald, Councillor | Amministratore | 28 Wilton Gardens Shirley SO15 7QR Southampton Hampshire | England | British | Transco N R A | 87840280001 | ||||
MCALISTER, Lewis John Woodburn | Amministratore | Woodburn House School Road, Ardington OX12 8PE Wantage Oxfordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 114352170001 | ||||
MCGILLICUDDY, Mark Howard | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | United Kingdom | British | Company Director | 167601310002 | ||||
MUNSEY, Jonathan Ross | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | British | Solicitor | 113783280001 | |||||
REES, David Rocyn | Amministratore | The Old Farm House Russells Water RG9 6ER Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | Director Of Investor Relations | 173477160001 | ||||
SARGENT, John Francis | Amministratore | 39 Foxhunter Drive LE2 5FG Oadby Leicester | British | Gas Engineer | 60162840001 | |||||
SIMPSON, Donald Uriah | Amministratore | 1-3 Strand London WC2N 5EH | England | British | Director | 175686010001 | ||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LATTICE GPS (LETTERS OF CREDIT) NOMINEE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Grid Uk Pension Scheme Trustee Limited | 06 apr 2016 | Strand WC2N 5EH London 1-3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0