PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04406514 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED?
- fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base (20140) / Industrie manifatturiere
Dove si trova PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Mills Canal Street DE1 2RJ Derby Derbyshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PINCO 1754 LIMITED | 28 mar 2002 | 28 mar 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 15 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2017 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 044065140007 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX a The Mills Canal Street Derby Derbyshire DE1 2RJ in data 12 ott 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Lee Jon Ali come amministratore in data 09 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anne Marie Frye come amministratore in data 09 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Vincent Preziotti come amministratore in data 09 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Philip Ray Gillespie come amministratore in data 09 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 08 giu 2015 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 044065140007, creata il 08 lug 2015 | 16 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2014 | 22 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Richard Vincent Preziotti come amministratore in data 31 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Anne Marie Frye come amministratore in data 31 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Prima Secretary Limited come segretario in data 31 ott 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Nomina di Philip Ray Gillespie come amministratore in data 31 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Dock Road Northside Workington Cumbria CA14 1JJ a St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX in data 17 nov 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Dock Road Northside Workington Cumbria CA14 1JJ | 1 pagine | AD04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Neil Work come amministratore in data 31 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Segretario | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
| 94529700001 | ||||||||||
| ALI, Lee Jon | Amministratore | Canal Street DE1 2RJ Derby The Mills Derbyshire | England | British | 212024290001 | |||||||||
| JACKS, Gillian | Segretario | Dock Road Northside CA14 1JJ Workington Cumbria | British | 108466430001 | ||||||||||
| PORTEOUS, Derek Leslie | Segretario | Charlson House Eaglesfield CA13 0SD Cockermouth Cumbria | British | 17311730001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||||||
| CONNOR, Howard | Amministratore | Broughton Manor Little Broughton CA13 0YG Cockermouth Cumbria | British | 56250580001 | ||||||||||
| FISHER, Ronald | Amministratore | Dock Road Northside CA14 1JJ Workington Cumbria | United Kingdom | British | 155652880001 | |||||||||
| FRYE, Anne Marie | Amministratore | N. Illinois Street Suite 1800 46204 Indianapolis 201 Indiana Usa | Usa | American | 192667000001 | |||||||||
| GILLESPIE, Philip Ray | Amministratore | N. Illinois Street Suite 1800 46204 Indianapolis 201 Indiana Usa | Usa | United States | 192667240001 | |||||||||
| JACKS, Gillian | Amministratore | Dock Road Northside CA14 1JJ Workington Cumbria | England | British | 108466430003 | |||||||||
| KENDALL, Robert Bradley | Amministratore | 32 Russell Road W14 8HU London | United Kingdom | British | 81809130002 | |||||||||
| LINDOP, Nicholas Anthony | Amministratore | Dock Road Northside CA14 1JJ Workington Cumbria | United Kingdom | British | 128147810002 | |||||||||
| LLOYD, Alastair John | Amministratore | Dock Road Northside CA14 1JJ Workington Cumbria | England | British | 82428170008 | |||||||||
| MACBEAN LAING, Allan | Amministratore | Dock Road Northside CA14 1JJ Workington Cumbria | England | British | 81809110001 | |||||||||
| MASH, Julian Paul Vivian | Amministratore | 23 Norland Square W11 4PU London | British | 29275230002 | ||||||||||
| PORTEOUS, Derek Leslie | Amministratore | Charlson House Eaglesfield CA13 0SD Cockermouth Cumbria | British | 17311730001 | ||||||||||
| PREZIOTTI, Richard Vincent | Amministratore | N. Illinois Street Suite 1800 46204 Indianapolis 201 Indiana Usa | United States | American | 193245630001 | |||||||||
| WORK, David Neil, Dr | Amministratore | Dock Road Northside CA14 1JJ Workington Cumbria | England | British | 112477020001 | |||||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 08 lug 2015 Consegnato il 08 lug 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 22 nov 2013 Consegnato il 02 dic 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 04 dic 2009 Consegnato il 15 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 09 set 2009 Consegnato il 10 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company with full title guarantee transfers and assigns to the chargee by way of first legal mortgage as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities. The mortgaged chattels 1 stainless steel oil fired reactor capacity 4500L, stainless steel oil fired reactor capacity 18000 l, stainless steel oil fired reactor capacity 6000L details of further chattels please see form 395. see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 08 set 2004 Consegnato il 16 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 dic 2003 Consegnato il 23 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture deed | Creato il 10 mag 2002 Consegnato il 15 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
PENTAGON CHEMICAL SPECIALTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0