COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04414667 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SYDNEY & BIRMINGHAM 2 LIMITED | 11 apr 2002 | 11 apr 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 43 pagine | 4.71 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Kenneth Robertson come amministratore in data 24 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 11 apr 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Treacy come amministratore in data 05 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Neil Kenneth Robertson come amministratore in data 05 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Treacy come amministratore in data 14 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fraser James Kennedy come amministratore in data 14 ago 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 01 lug 2013 | 2 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Fraser James Kennedy il 01 lug 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ* in data 02 lug 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520001 | ||||||||||
| VALSEC DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom |
| 102622300002 | ||||||||||
| CURTIS, Wendy June | Segretario | 136 Henke Court Schooner Way Atlantic Wharf CF10 4EL Cardiff | British | 46982690003 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Segretario | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
| CHALFEN SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013320001 | |||||||||||
| ANNING, Richard John | Amministratore | Witchwood Westra CF64 4HA Dinas Powys Vale Of Glamorgan | Wales | British | 14073020003 | |||||||||
| CHILDS, Simon John | Amministratore | 18 Hardwicke Court Llandaff CF5 2LB Cardiff | Wales | British | 78425720001 | |||||||||
| CURTIS, Wendy June | Amministratore | 136 Henke Court Schooner Way Atlantic Wharf CF10 4EL Cardiff | British | 46982690003 | ||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Amministratore | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Amministratore | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 121610350003 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Amministratore | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 135717740001 | |||||||||
| ROBERTSON, Neil Kenneth | Amministratore | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 158937210001 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Amministratore | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Amministratore | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TREACY, Claire | Amministratore | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| CHALFEN NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013310001 | |||||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 22 mar 2012 Consegnato il 30 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land to the north east of old park road wednesbury t/no WM398013 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and charge | Creato il 28 ago 2009 Consegnato il 11 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 nov 2002 Consegnato il 22 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 nov 2002 Consegnato il 22 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h and l/h property k/a all saints business park all saints road wednesbury west midlands WS10 9TS t/nos WM398013 and WM695818. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed (supplemental to a deed dated 18 august 1998) | Creato il 16 apr 2002 Consegnato il 27 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the charged properties together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over shares | Creato il 16 apr 2002 Consegnato il 27 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 16 apr 2002 Acquisito il 16 apr 2002 Consegnato il 24 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The property k/a all saints road wednesbury t/n WM695818 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0