P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED

P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàP.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04417900
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    P.J. LIVESEY (CLAYBURY) LIMITED 16 apr 200216 apr 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al16 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma30 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al16 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Modifica dei dettagli di P J Livesey North Limited come persona con controllo significativo il 01 gen 2017

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2023

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2022

    13 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 044179000007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 044179000006 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Ralph Brocklehurst come amministratore in data 01 ago 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2021

    13 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2020

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Memorandum e Statuto

    4 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 28/02/2014
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2019

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Georgina Ann Livesey il 18 mar 2020

    2 pagineCH01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 2

    2 pagineMR05

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2018

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Gary Wayne Graves come amministratore in data 01 feb 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John William Allcock come amministratore in data 10 nov 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Craig Daniel Lynch come amministratore in data 22 ott 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Duckett come amministratore in data 22 ott 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LIVESEY, Dorothea Anne
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Segretario
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    BritishDirector1923690003
    DUCKETT, Mark
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    EnglandBritishDirector140882970001
    LIVESEY, Dorothea Anne
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    EnglandBritishDirector1923690003
    LIVESEY, Peter Joseph
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    EnglandBritishManaging Director70887980002
    LYNCH, Craig Daniel
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    United KingdomBritishDirector236663670001
    LYNCH, Georgina Ann
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    United KingdomBritishDirector183712430002
    WOODMANSEE, James Nicholas David
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    EnglandBritishDirector80182950002
    DUPORT SECRETARY LIMITED
    2 Southfield Road
    BS9 3BH Westbury On Trym
    The Bristol Office
    Bristol
    Segretario nominato
    2 Southfield Road
    BS9 3BH Westbury On Trym
    The Bristol Office
    Bristol
    900020060001
    ALLCOCK, John William
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    United KingdomBritishFinancial Director65584380002
    BROCKLEHURST, Ralph
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    EnglandBritishTechnical Director78429110007
    GRAVES, Gary Wayne
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    EnglandBritishDirector250793180001
    RICHARDSON, Paul Gerard
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    Amministratore
    Ashburton Park Ashburton Road
    West Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    EnglandBritishDevelopment Director65584490001
    DUPORT DIRECTOR LIMITED
    2 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BH Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BH Bristol
    900020050001

    Chi sono le persone con controllo significativo di P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Beacon Road
    Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    P J Livesey Holdings Limited
    England
    01 gen 2017
    Beacon Road
    Trafford Park
    M17 1AF Manchester
    P J Livesey Holdings Limited
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04339759
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    P.J. LIVESEY HERITAGE HOMES NORTH WEST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2014
    Consegnato il 07 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land adjoining mostyn house school, parkgate, neston t/no CH348260. Mostyn house school, the parade, parkgate, neston t/no's CH300729 and CH624327.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 mar 2014
    Consegnato il 13 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2013
    Consegnato il 12 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H property at mmostyn house school edged red on the plan attached to teh legal mortgage t/nos CH300729 and CH348260. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Suzanne Mary Tracy Grenfell
    • Lynda Anna April Armstrong
    Transazioni
    • 12 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 2011
    Consegnato il 03 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Oak barn, lower mountain road, penyfford, chester, t/no: CYM329762 and CYM201554 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 set 2006
    Consegnato il 29 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Crossley hospital east kingswood nr frodsham cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and equitable charge
    Creato il 08 ago 2006
    Consegnato il 15 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings as crossley hospital east kingswood nera frosham cheshire.
    Persone aventi diritto
    • The Crown Estate Commissioners on Behalf of Her Majesty
    Transazioni
    • 15 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2020Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 06 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 feb 2003
    Consegnato il 10 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0