STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED

STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04423033
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BEGBIES
    9 Bonhill Street
    EC2A 4DJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 giu 2016

    Stato del capitale al 13 giu 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Cessazione della carica di Ruth Wilma Williams come amministratore in data 23 giu 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Ronald Williams come amministratore in data 23 giu 2015

    2 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1St Floor Epworth House 25 City Road London EC1Y 1AR a C/O Begbies 9 Bonhill Street London EC2A 4DJ in data 21 nov 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2014

    Stato del capitale al 06 mag 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ruth Wilma Williams il 24 apr 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Guarantee 20/04/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANG, Jacqueline Mary
    Wigton House Wigton Lane
    Alwoodley
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Wigton House Wigton Lane
    Alwoodley
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    British3648270001
    LANG, Jacqueline Mary
    Wigton House Wigton Lane
    Alwoodley
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wigton House Wigton Lane
    Alwoodley
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishProperty Developer3648270001
    LANG, Martin Allen
    Wigton House Wigton Lane
    Alwoodley
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wigton House Wigton Lane
    Alwoodley
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish,Property Developer4153450001
    RWL REGISTRARS LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    Segretario nominato
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    900007870001
    WILLIAMS, David Ronald
    The Grange Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9JB Leeds
    Amministratore
    The Grange Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9JB Leeds
    EnglandBritishCommercial Property Consultant10620750003
    WILLIAMS, Ruth Wilma
    The Grange
    Leeds Road Bramhope
    LS16 9JB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Grange
    Leeds Road Bramhope
    LS16 9JB Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishProperty Investor116051420001

    STAINSBY GRANGE (WOMBWELL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 nov 2006
    Consegnato il 24 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 24 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 2006
    Consegnato il 24 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property being land and buildings on the east and south side of bleach croft way, stairfoot, barnsley t/no. SYK450533. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 24 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 02 ago 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being land and buildings on the east and south side of bleach croft way barnsley t/no: SYK450583. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture (floating charge)
    Creato il 02 ago 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mag 2002
    Consegnato il 21 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Properties k/a freehold land lying to the south west of wombwell lane stairfoot barnsley south yorkshire t/n YWE2131, freehold property k/a land and buildings on the west side of the sheffield and south yorkshire navigation dearne and dove canal together with part of such disused canal part t/n SYK414491 for further properties please refer to form 395 together with the proceeds of sale and all buildings and trade and other fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 21 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0