EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC
Panoramica
| Nome della società | EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Numero di società | 04426513 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
| Indirizzo della sede legale | C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) LIMITED | 20 mag 2002 | 20 mag 2002 |
| PRIZEDRIVE LIMITED | 29 apr 2002 | 29 apr 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 29 apr 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 13 mag 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 29 apr 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio intermedio redatto al 30 giu 2025 | 15 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 apr 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 33 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Cameron Hannah Mclure il 31 gen 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Mr Cameron Hannah Mclure come amministratore in data 31 gen 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio intermedio redatto al 30 giu 2024 | 14 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 34 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Steve Marc Prior il 10 mag 2024 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 apr 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Martin Timothy Smith come amministratore in data 08 gen 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio intermedio redatto al 30 giu 2023 | 14 pagine | AA | ||
Nomina di Albany Secretariat Limited come segretario in data 20 lug 2023 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Alison Louise Mitchell come segretario in data 20 lug 2023 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 32 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Martin Timothy Smith come amministratore in data 01 dic 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Leslie Tennant come amministratore in data 30 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio intermedio redatto al 30 giu 2022 | 14 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 32 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Paul Millsom il 13 mar 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Mr Frank David Laing come amministratore in data 14 feb 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Karen Marie Hill come amministratore in data 14 feb 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio intermedio redatto al 30 giu 2021 | 14 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 32 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Segretario | Charlotte Street M1 4HB Manchester 3-5 England |
| 303585870001 | ||||||||||
| DONN, Michael Andrew | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 108352120001 | |||||||||
| LAING, Frank David | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| MCLURE, Cameron Hannah | Amministratore | c/o Abrdn George Street EH2 2LL Edinburgh 1 Scotland | Scotland | British | 331954720002 | |||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 190982570023 | |||||||||
| PRIOR, Steven Marc | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 225624930003 | |||||||||
| SOLLEY, Christopher Thomas | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | 166666620001 | |||||||||
| MITCHELL, Alison Louise | Segretario | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | British | 85439080001 | ||||||||||
| MOSS, James Henry | Segretario | 28a Somerfield Road N4 2JJ London | British | 79742730001 | ||||||||||
| HLM SECRETARIES LIMITED | Segretario | 1st Floor 25 Stamford Street WA14 1EX Altrincham Cheshire | 118686920001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ANDERSON, Thomas Downs | Amministratore | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | 54976140002 | |||||||||
| ASHBROOK, Philip Peter | Amministratore | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 121252960001 | |||||||||
| BRADLEY, Victoria Louise | Amministratore | 26 Fitzgerald Avenue SW14 8SZ London | United Kingdom | British | 126733230001 | |||||||||
| BRUNNING, Charlotte Louise | Amministratore | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 242374880001 | |||||||||
| CAMP, David John | Amministratore | 236 St Magaret's Road TW1 1NL Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 4807190003 | |||||||||
| CAVE, David Anthony | Amministratore | Flat 4 135 Breakspears Road SE4 1TY Brockley London | British | 82164230001 | ||||||||||
| DAVIS, Michael Edward | Amministratore | Guy Lane CH3 7RZ Waverton Stapleford House Chester | United Kingdom | British | 131261410001 | |||||||||
| DICKIE, Timothy John | Amministratore | 51 Summerside Place EH6 4NY Edinburgh | British | 107164130002 | ||||||||||
| DONN, Michael Andrew | Amministratore | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | Scotland | British | 184269980001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GORMAN, Derek Robert | Amministratore | 22 Sealstrand Dalgety Bay KY11 9NG Dunfermline Fife | British | 65470990001 | ||||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Amministratore | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 206362380001 | |||||||||
| HEANEY, William Alexander | Amministratore | Clematis Cottage 14 Deanway HP8 4JH Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 2538150001 | |||||||||
| HILL, Karen Marie | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 193296740001 | |||||||||
| HOCKADAY, Stephen | Amministratore | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | 101894100001 | |||||||||
| HOILE, Richard David | Amministratore | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | United Kingdom | British | 137848430002 | |||||||||
| JACKSON, Gregor Scott | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | 191227420001 | |||||||||
| LEWIS, Frederick Paul | Amministratore | 24 Riddy Lane Bourn CB3 7SP Cambridge Cambridgeshire | England | British | 15107950001 | |||||||||
| LIPTON, Stuart Anthony, Sir | Amministratore | 40 Queens Grove NW8 6HH London | England | British | 2068540001 | |||||||||
| MCDONAGH, John | Amministratore | 7 Brocklebank Road SW18 3AP London | British | 94012300001 | ||||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Amministratore | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | England | British | 156461120001 | |||||||||
| MOSS, James Henry | Amministratore | 28a Somerfield Road N4 2JJ London | British | 79742730001 | ||||||||||
| MULLER, Andrew John | Amministratore | Flat 4 7 Barkston Gardens Earls Court SW5 0ER London | Australian | 77022680001 | ||||||||||
| MURPHY, Helen Mary | Amministratore | C/O Catalyst Lend Lease 3rd Floor The Venus M41 7HG 1 Old Park Lane Trafford Manchester | England | Irish | 156461710001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EXCHEQUER PARTNERSHIP (NO.2) PLC?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchequer Partnership (No. 2) Holdings Limited | 03 set 2016 | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0