TULA GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTULA GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04433635
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TULA GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TULA GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o EY
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TULA GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPEED 9165 LIMITED08 mag 200208 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TULA GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TULA GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Jayne Mary Worden come amministratore in data 11 dic 2019

    1 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 gen 2019

    10 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Radley, 3rd Floor Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW a C/O Ey 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 feb 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 gen 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 gen 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of the share premium account and cancellation of the capital redemption reserve 25/01/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 apr 2016

    15 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Roger Clive Best come amministratore in data 03 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gregory Pratt come segretario in data 03 giu 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Naomi Halliday come amministratore in data 03 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas James Vance come amministratore in data 03 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2016

    Stato del capitale al 03 feb 2016

    • Capitale: GBP 264,250
    SH01

    Bilancio redatto al 30 apr 2015

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Justin Paul David Stead come amministratore in data 07 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Xavier Marie Olivier Simonet come amministratore in data 08 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2014

    AA

    Chi sono gli amministratori di TULA GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STEAD, Justin Paul David
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandAmerican204126530001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Segretario
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    British67243220003
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    PRATT, Gregory
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Segretario
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    167192940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLEN, Pelham Brian
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish166398180001
    BEST, Roger Clive
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Amministratore
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish114728210001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Amministratore
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Amministratore
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish67243220004
    CORLETT, Anthony John Darcy
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Amministratore
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    United KingdomBritish37929030005
    ENEVOLDSON, Karl Thyge
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    Amministratore
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    British87906250001
    GAEDE, Sven Willi Swithin
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Amministratore
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish122640470001
    HALLIDAY, Naomi
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Amministratore
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    United KingdomBritish184787710001
    HARDER, Lowell Judith
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    Amministratore
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    UkAustralian26244220001
    LISTER, Ivan James
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    Amministratore
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    United KingdomBritish67150960004
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    RODRIGUES, Selwyn Mario Pius
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    Amministratore
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    British78514760004
    SIMONET, Xavier Marie Olivier
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Amministratore
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandFrench184753700001
    VANCE, Nicholas James
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Amministratore
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish184753710001
    WARNER, Alan Mark
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    Amministratore
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    United KingdomBritish119324870001
    WORDEN, Jayne Mary
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish109333140001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TULA GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    06 apr 2016
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5707910
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TULA GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 dic 2007
    Consegnato il 18 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from each obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 1 site b brundell drive brinklow mi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 18 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 12 lug 2006
    Consegnato il 01 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 10 lug 2006
    Consegnato il 14 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re tula group LTD and numbered 2061452 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respectthereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 feb 2006
    Consegnato il 09 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 1, site b, brundell drive, brinklow, milton keynes t/n BM296212. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 09 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 feb 2003
    Consegnato il 11 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 11 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 feb 2003
    Consegnato il 28 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alan Mark Warner, Malcolm Warner, Christopher Howell and Peter Myers
    Transazioni
    • 28 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 feb 2003
    Consegnato il 28 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lowell Judith Harder
    Transazioni
    • 28 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TULA GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2018Inizio della liquidazione
    12 feb 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Joseph Luke Carleton
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Praticante
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Praticante
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0