PROFIVE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROFIVE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04433872
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROFIVE LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova PROFIVE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    53 53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROFIVE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ONYXTOWER LIMITED08 mag 200208 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROFIVE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PROFIVE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 apr 2019

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 apr 2018

    12 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 apr 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 53 Fore Street Ivybridge Devon PL21 9AE England a 53 53 Fore Street Ivybridge Devon PL21 9AE in data 10 mar 2017

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sannerville Chase Exminster Exeter Devon EX6 8AT a 53 Fore Street Ivybridge Devon PL21 9AE in data 09 mar 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gerald John Tranckle il 08 ago 2016

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 044338720013 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mar 2016

    Stato del capitale al 29 mar 2016

    • Capitale: GBP 300
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 044338720013, creata il 21 lug 2015

    8 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2015

    Stato del capitale al 25 mar 2015

    • Capitale: GBP 300
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 044338720012 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2014

    Stato del capitale al 25 mar 2014

    • Capitale: GBP 300
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    11 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 044338720012

    10 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di PROFIVE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KNIGHT, Adrian Timothy
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    Segretario
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    BritishChartered Accountant73020680001
    JOHNSON, David Robin
    Heather Banks
    The Vineyard
    TQ9 6HW Dartington
    Devon
    Amministratore
    Heather Banks
    The Vineyard
    TQ9 6HW Dartington
    Devon
    United KingdomBritishArchitect100080410001
    KNIGHT, Adrian Timothy
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    Amministratore
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    EnglandBritishChartered Accountant73020680001
    LEE, Philip Robert
    97 Sidford Road
    EX10 9NR Sidmouth
    Devon
    Amministratore
    97 Sidford Road
    EX10 9NR Sidmouth
    Devon
    EnglandBritishQuantity Surveyor31827310003
    TRANCKLE, Gerald John
    6 The Coppice
    Dawlish
    Oaklea
    Devon Ex7 0ln
    United Kingdom
    Amministratore
    6 The Coppice
    Dawlish
    Oaklea
    Devon Ex7 0ln
    United Kingdom
    EnglandBritishBuilder68972180006
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    CUSA, Peter John
    65 Clyst Valley Road
    Clyst St. Mary
    EX5 1DE Exeter
    Devon
    Amministratore
    65 Clyst Valley Road
    Clyst St. Mary
    EX5 1DE Exeter
    Devon
    United KingdomBritishArchitect126644870001
    WILLOCKS, Sydney George
    Tenggara
    30 Newton Road
    TQ14 9PN Bishopsteignton
    Devon
    Amministratore
    Tenggara
    30 Newton Road
    TQ14 9PN Bishopsteignton
    Devon
    United KingdomBritishEngineer65888730002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PROFIVE LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    25 mar 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    PROFIVE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 lug 2015
    Consegnato il 22 lug 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The owner, as a continuing security for the payment on demand of the owner's obligations and with full title guarantee charges to the bank by way of legal mortgage all legal interest in the property, being land to rear of crooks cross known as raleigh mead, south molton, devon registered at the land registry with title number DN636466 and gives to the bank a fixed charge over any other interest in the property.. Please see charge document for more details.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2013
    Consegnato il 15 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H land as land and buildings lying to the north of cooks cross, south molton, devon t/no DN393761. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2011
    Consegnato il 24 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The old post office, old newton road, heathfield, newton abbot t/no DN515089. By way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 30 set 2010
    Consegnato il 08 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The old post office, old newton road, heathfield, newon abbot t/no DN515089.
    Persone aventi diritto
    • Ravenslade Limited
    Transazioni
    • 08 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 apr 2007
    Consegnato il 25 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The old fire station, first avenue, teig. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 09 mar 2007
    Consegnato il 16 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    16/17 charlotte street crediton devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 2005
    Consegnato il 04 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at chittlehampton umberleigh devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 17 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ridgeway 71 teignmouth road teignmouth devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 mag 2004
    Consegnato il 29 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 2003
    Consegnato il 29 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £240,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property known as former milber post office 11 pinewood road newton abbot devon. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £122,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    25 maudlin drive teignmouth devon TQ14 8RZ. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 2002
    Consegnato il 30 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £115,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a 12 hazeldown road teignmouth devon. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 2002
    Consegnato il 26 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £130,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a 5 derncleugh gardens, holcombe, dawlish EX7 0JG. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PROFIVE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 set 2020Data di scioglimento
    12 apr 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samuel Adam Bailey
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    Praticante
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    Hamish Millen Adam
    Richard J Smith & Co
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    Praticante
    Richard J Smith & Co
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0