CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04435931 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARILLION RICHARDSON THANET PHASE 2 LIMITED | 08 lug 2003 | 08 lug 2003 |
| CHELVERTON GROUP (THANET) LIMITED | 10 mag 2002 | 10 mag 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2020 | 10 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY United Kingdom a Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 29 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY in data 20 dic 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Cr Limited come persona con controllo significativo il 12 dic 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Paul Eastwood come amministratore in data 12 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Paul Eastwood il 01 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Cr Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come segretario in data 11 set 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDSON, Lee Scott | Amministratore | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | United Kingdom | English | 66581210001 | |||||
| RICHARDSON, Martyn Ford | Amministratore | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | United Kingdom | English | 66581140001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| HOWCROFT, Martyn Jonathan | Segretario | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | British | 8333740002 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235181670001 | |||||||
| MANIN, Richard Raymond Emile | Segretario | 236 Sheen Lane East Sheen SW14 8RL London | British | 29741390003 | ||||||
| ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| CARTISSER, Matthew Grant | Amministratore | Leighton Manor Farm Spode Lane TN8 7HN Cowden Kent | United Kingdom | British | 82316750001 | |||||
| COLLETT, Brian | Amministratore | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| EASTWOOD, Simon Paul | Amministratore | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | 35184590004 | |||||
| GIRLING, Christopher Francis | Amministratore | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| MANIN, Richard Raymond Emile | Amministratore | 236 Sheen Lane East Sheen SW14 8RL London | United Kingdom | British | 29741390003 | |||||
| MORGAN, Simon Bruce | Amministratore | Netherhope House Netherhope Lane NP16 7JG Tidenham Gloucestershire | England | British | 86142950001 | |||||
| RICHARDSON, Donald Barrie | Amministratore | 100 Dudley Road East B69 3DY Oldbury West Midlands | British | 44851070002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Cr Limited | 06 apr 2016 | Dudley Road East B69 3DY Oldbury, Warley 100 West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Foxborough Developments Limited | 06 apr 2016 | Dudley Road East B69 3DY Oldbury 100 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security interest agreement | Creato il 07 nov 2008 Consegnato il 26 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The original collateral, an instrument of transfer the original notice see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 nov 2008 Consegnato il 26 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 30 giu 2004 Consegnato il 15 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plot no. A and b (part of plots 9 and 19) premises at land associated with wickes building supplies limited margate road broadstairs and 3 haine road broadstairs and land at the rear administrative area thanet kent t/no. Part K733066 and part K852142. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 02 apr 2004 Acquisito il 25 giu 2004 Consegnato il 16 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge debenture | Creato il 02 apr 2004 Consegnato il 10 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 dic 2003 Acquisito il 25 giu 2004 Consegnato il 16 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 24 dic 2003 Consegnato il 10 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land associated with wickes building supplies limited, margate road, broadstairs, t/n K733066. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0