CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED

CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCEDAR THANET PHASE 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04435931
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Frp Advisory Llp 2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARILLION RICHARDSON THANET PHASE 2 LIMITED08 lug 200308 lug 2003
    CHELVERTON GROUP (THANET) LIMITED10 mag 200210 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2020

    10 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY United Kingdom a Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 29 lug 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 11 lug 2019

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 gen 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 dic 2018

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY in data 20 dic 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Carillion Cr Limited come persona con controllo significativo il 12 dic 2018

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Simon Paul Eastwood come amministratore in data 12 dic 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Paul Eastwood il 01 ott 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Carillion Cr Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Westley Maffei come segretario in data 11 set 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RICHARDSON, Lee Scott
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Amministratore
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    United KingdomEnglishDirector66581210001
    RICHARDSON, Martyn Ford
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Amministratore
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    United KingdomEnglishDirector66581140001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Segretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    HOWCROFT, Martyn Jonathan
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Segretario
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    British8333740002
    MAFFEI, Westley
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Segretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    235181670001
    MANIN, Richard Raymond Emile
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    Segretario
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    BritishDirector29741390003
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director67133560004
    CARTISSER, Matthew Grant
    Leighton Manor Farm
    Spode Lane
    TN8 7HN Cowden
    Kent
    Amministratore
    Leighton Manor Farm
    Spode Lane
    TN8 7HN Cowden
    Kent
    United KingdomBritishDirector82316750001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Amministratore
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    BritishCompany Director32267100002
    EASTWOOD, Simon Paul
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor35184590004
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Amministratore
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    BritishFinance Director67125270002
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Finance Director195408780001
    MANIN, Richard Raymond Emile
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    Amministratore
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    United KingdomBritishDirector29741390003
    MORGAN, Simon Bruce
    Netherhope House
    Netherhope Lane
    NP16 7JG Tidenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Netherhope House
    Netherhope Lane
    NP16 7JG Tidenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishProperty Developer86142950001
    RICHARDSON, Donald Barrie
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Amministratore
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    BritishCompany Director44851070002

    Chi sono le persone con controllo significativo di CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury, Warley
    100
    West Midlands
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury, Warley
    100
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3783015
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    100
    England
    06 apr 2016
    Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    100
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03833633
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security interest agreement
    Creato il 07 nov 2008
    Consegnato il 26 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The original collateral, an instrument of transfer the original notice see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 nov 2008
    Consegnato il 26 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 15 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot no. A and b (part of plots 9 and 19) premises at land associated with wickes building supplies limited margate road broadstairs and 3 haine road broadstairs and land at the rear administrative area thanet kent t/no. Part K733066 and part K852142. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 apr 2004
    Acquisito il 25 giu 2004
    Consegnato il 16 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2004Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 19 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge debenture
    Creato il 02 apr 2004
    Consegnato il 10 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 dic 2003
    Acquisito il 25 giu 2004
    Consegnato il 16 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Part of the f/h property k/a 3 haine road and land at the rear, broadstairs kent t/n K852142.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2004Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 19 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 dic 2003
    Consegnato il 10 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land associated with wickes building supplies limited, margate road, broadstairs, t/n K733066. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CEDAR THANET PHASE 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 lug 2019Inizio della liquidazione
    05 nov 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gerald Clifford Smith
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Arvindar Jit Singh
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0