UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED

UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04436257
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Thompson Taraz Llp 4th Floor, Stanhope House
    47 Park Lane
    W1K 1PR London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DWSCO 2289 LIMITED13 mag 200213 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 35 Grosvenor Street London W1K 4QX a C/O Thompson Taraz Llp 4th Floor, Stanhope House 47 Park Lane London W1K 1PR in data 09 set 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2015

    Stato del capitale al 23 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2014

    Stato del capitale al 09 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Grieve il 28 feb 2013

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Andrew Grieve come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Martin Grieve come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew David Grieve come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Sullivan come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sally King come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 64 North Row 5Th Floor London W1K 7DA England* in data 31 ott 2011

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2011

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Amir Zaidi come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEFFERNAN, Martin Michael
    4th Floor, Stanhope House
    47 Park Lane
    W1K 1PR London
    C/O Thompson Taraz Llp
    England
    Amministratore
    4th Floor, Stanhope House
    47 Park Lane
    W1K 1PR London
    C/O Thompson Taraz Llp
    England
    United KingdomBritish86195170001
    DEVINE, David John
    105 Nelson Road
    South Wimbledon
    SW19 1HU London
    Segretario
    105 Nelson Road
    South Wimbledon
    SW19 1HU London
    British117499680002
    EDELSTEIN, Tony Warren
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    Segretario
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    British46507060001
    KING, Sally Frances
    Grosvenor Street
    W1K 4QX London
    35
    United Kingdom
    Segretario
    Grosvenor Street
    W1K 4QX London
    35
    United Kingdom
    152869920001
    MAGNUS, Alan Melvyn
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    British88944620002
    SULLIVAN, Anthony Nicholas John
    10 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Segretario
    10 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British1823720001
    WILLIAMSON, Edward Leigh
    Upland Road
    CR2 6RE South Croydon
    31
    Surrey
    Segretario
    Upland Road
    CR2 6RE South Croydon
    31
    Surrey
    British137886520001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario nominato
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    EDELSTEIN, Tony Warren
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    Amministratore
    74 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HL London
    British46507060001
    GRIEVE, Andrew David
    Grosvenor Street
    W1K 4QX London
    35
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QX London
    35
    United Kingdom
    United KingdomBritish129540950001
    KING-CLINE, Anthony Laurence
    16 Folkington Corner
    N12 7BH London
    Amministratore
    16 Folkington Corner
    N12 7BH London
    United KingdomBritish34461460001
    MAGNUS, Alan Melvyn
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    Autumn Leaves
    Latimer Road Monken
    EN5 5NU Hadley Barnet
    Hertfordshire
    British88944620002
    NORRIS, Anthony Carmelo
    Little Hollow
    Seal Hollow Road
    TN13 3SF Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Little Hollow
    Seal Hollow Road
    TN13 3SF Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish70951730005
    SULLIVAN, James Alistair
    Grosvenor Street
    W1K 4QX London
    35
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QX London
    35
    United Kingdom
    United KingdomBritish126441710003
    TRUSTRAM EVE, John Richard
    Astra Court
    Hythe
    SO45 6DZ Southampton
    2
    Hampshire
    Amministratore
    Astra Court
    Hythe
    SO45 6DZ Southampton
    2
    Hampshire
    EnglandBritish2751740003
    ZAIDI, Amir Hassan
    North Row
    5th Floor
    W1K 7DA London
    64
    England
    Amministratore
    North Row
    5th Floor
    W1K 7DA London
    64
    England
    EnglandBritish148106780001
    ZAIDI, Amir Hassan
    North Row
    5th Floor
    W1K 7DA London
    64
    England
    Amministratore
    North Row
    5th Floor
    W1K 7DA London
    64
    England
    United KingdomBristish149402600001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Amministratore delegato nominato
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001

    UK HOSPITALS NO. 1 (PT2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the property trustees to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the benefit of the rent rebate (jt) rights (all as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • UK Hospitals No.1 Trustee (Jersey) Limited (the Beneficiary)the Beneficiary Has Assigned the Benefit of Thesecurity Agreement to Bupa Hospitals (Holdings)Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital oadby leicester.
    Persone aventi diritto
    • Lunar Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital southampton.
    Persone aventi diritto
    • Lunar Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital harpenden.
    Persone aventi diritto
    • Lunar Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa barnston wirral.
    Persone aventi diritto
    • Lunar Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital bushey.
    Persone aventi diritto
    • Lunar Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital roundhay leeds.
    Persone aventi diritto
    • Lunar Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital cardiff.
    Persone aventi diritto
    • Lunar Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital watton road colney norwich.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Properties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital warrington.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Properties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital whalley range manchester.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Properties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital little aston staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Properties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital riding lane south ilford.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Properties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge the interest of the chargors in the property k/a bupa hospital havant portsmouth.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Properties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Asecurity agreement
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 05 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited partnership to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed equitable charge all of the property trustees' right, title and interest in and to the benefit of the headleases. The jt rent rights. Jt/pt security agreement. The deposit.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bupa Hospitals (Holdings) Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0