TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED

TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04439517
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5th Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECIS (2240) LIMITED15 mag 200215 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01
    X9I3RKJS

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    8 pagineAA
    A96LQG0J

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X9603SWI

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X864KXRM

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    8 pagineAA
    L824GGVK

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X76Y6JMH

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    9 pagineAA
    L72QXOPL

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X6727EQH

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    9 pagineAA
    A6370Y0B

    Cessazione della carica di Waheena Wingham come amministratore in data 19 dic 2016

    1 pagineTM01
    X60PQWOO

    Cessazione della carica di Vincent Aziz Tchenguiz come amministratore in data 19 dic 2016

    1 pagineTM01
    X60PQWDV

    Cessazione della carica di Dror Pasher come amministratore in data 19 dic 2016

    1 pagineTM01
    X60PQW8I

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Aziz Tchenguiz il 01 lug 2016

    2 pagineCH01
    X5ANBB2X

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2016

    Stato del capitale al 01 giu 2016

    • Capitale: GBP 4
    SH01
    X588UXXK

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    9 pagineAA
    L4MGLC97

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 giu 2015

    Stato del capitale al 04 giu 2015

    • Capitale: GBP 4
    SH01
    X48UZOZS

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2013 al 30 giu 2014

    1 pagineAA01
    X3HIKDKB

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA
    A3G3VT9S

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2014

    Stato del capitale al 27 mag 2014

    • Capitale: GBP 4
    SH01
    X38SDN8I

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Aziz Tchenguiz il 08 ott 2013

    2 pagineCH01
    X2JIZ44R

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA
    A2I06UWU

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    X29JD3I3

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    9 pagineAA
    A1I4SU41

    Chi sono gli amministratori di TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PAYNE, Mark Derick
    The Street
    Ash
    TN15 7HB Nr Sevenoaks
    White House
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    The Street
    Ash
    TN15 7HB Nr Sevenoaks
    White House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector163234160001
    WATSON, Michael David
    Highacre
    RH4 3BF Dorking
    27
    Surrey
    England
    Amministratore
    Highacre
    RH4 3BF Dorking
    27
    Surrey
    England
    EnglandBritishChartered Accountant63440350001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Segretario
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Segretario nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    LEADER, Lewis Isadore
    233 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    Amministratore
    233 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    AmercianProperty Developer6390720001
    PASHER, Dror
    Upper Grosvenor Street
    W1K 7PB London
    20
    Great Britain
    Amministratore
    Upper Grosvenor Street
    W1K 7PB London
    20
    Great Britain
    IsraelBritishProperty Developer62686040006
    TAYLOR, Paul Vincent
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    Amministratore
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    United KingdomBritishChief Executive71978710001
    TCHENGUIZ, Vincent Aziz
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Amministratore
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    United KingdomBritish,Company Director71890500005
    THORPE, Julian David
    Kings Lane
    RH13 8BD Cowfold
    Bankfield Grange
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Kings Lane
    RH13 8BD Cowfold
    Bankfield Grange
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor100357510002
    WINGHAM, Waheena
    2 Summit Drive
    IG8 8QP Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    2 Summit Drive
    IG8 8QP Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritishDirector85674800002
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Amministratore delegato nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    900019410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tindall Hotels (General Partner) Limited
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th Floor, Leconfield House
    England
    06 apr 2016
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th Floor, Leconfield House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione04482494
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TINDALL HOTELS HOLDCO 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 lug 2007
    Consegnato il 07 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    In respect of any chargor, all monies due or to become due from that chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Landesbank Acting Through Its London Branch as Security Trustee for the Financeparties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of confirmation in respect of a debenture with floating charge dated 16 december 2004
    Creato il 11 lug 2006
    Consegnato il 14 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Each of the Financeparties (The Agent)
    Transazioni
    • 14 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security interest agreement
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the grantor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Each of the Financeparties
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture with floating charge
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them)
    Brevi particolari
    All right, title and interest to and under all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants,warranties, representations and other documents in respect of the real property,as defined,and all rental income and disposal proceeds,insurance policies thereunder; fixed charge over all rights,title,interest and all shares owned by each holdco and monies standing to the credit of all accounts with any bank and the debts thereby; the goodwill of business,rights and claims in relation to uncalled capital,book and other debts and monetary claims due and all undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Each of the Financeparties
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture with floating charge
    Creato il 30 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Inclusive of "mortgaged property" as defined in form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Landesbank, London Branch. (As Trustee for the Finance Parties Under (and as Defined) in the Facility Agreement
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0