NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04440081 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LOMBARD CORPORATE FINANCE (18) LIMITED | 16 mag 2002 | 16 mag 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2021 al 31 mar 2022 | 1 pagine | AA01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Keith Damian Pereira il 07 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Lowe il 07 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2020 | 18 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 19 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Natwest Markets Secretarial Services Limited come segretario in data 26 giu 2019 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Rbs Secretarial Services Limited come segretario in data 26 giu 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 18 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Notifica di Distant Planet Productions Limited come persona con controllo significativo il 11 lug 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Royal Bank Leasing Limited come persona con controllo significativo il 10 lug 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||
Nomina di Mr Simon Charles Lowe come amministratore in data 26 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Stephen Paul Nixon come amministratore in data 26 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Quadrangle the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1PX a 250 Bishopsgate London London EC2M 4AA in data 12 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Ian Andrew Ellis come amministratore in data 08 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Keith Damian Pereira come amministratore in data 08 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| LOWE, Simon Charles | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 109835010002 | |||||||||
| PEREIRA, Keith Damian | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 London England | England | British | 239981580001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Segretario | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | British | 35994320001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Segretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| DOWN, Carolyn Jean | Segretario | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700004 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Segretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Amministratore | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Amministratore | The Promenade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CHILDS, Maureen Anne | Amministratore | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 35994320001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Amministratore | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| CROME, Trevor Douglas | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 186705800001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Amministratore | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| ELLIS, Ian Andrew | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 243996550001 | |||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Amministratore | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| GADSBY, Andrew Paul | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 74834980002 | |||||||||
| HARRIS, David Gerald | Amministratore | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 236842580001 | |||||||||
| JOHNSON, Alan Piers | Amministratore | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 155895050001 | |||||||||
| LATTER, William Vaughan | Amministratore | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| MAYES, Emma-Marie | Amministratore | The Quadrangle The Promenade GL50 1PX Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 258397370001 | |||||||||
| MCDAID, Neil Jason | Amministratore | EC2M 4RB London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 222279310001 | |||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PAYNE, Brian John | Amministratore | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | 38688940001 | |||||||||
| PEARCE, Nigel | Amministratore | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| ROGERS, Julian Edwin | Amministratore | 2 The Green RM15 6SD South Ockendon Nubbock House Essex England | England | British | 137180040001 | |||||||||
| ROULSTON, Steven James | Amministratore | Ground Floor, Business House F EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn, PO BOX 1000 Scotland | Scotland | British | 238205130001 | |||||||||
| SHEPHARD, Ian Maxwell | Amministratore | Hungerford House Pale Lane Winchfield RG27 8SW Hook Hampshire | British | 111421920002 | ||||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Amministratore | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 | |||||||||
| SULLIVAN, Christopher Paul | Amministratore | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey | United Kingdom | British | 67033830004 | |||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Amministratore | 10 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedforedshire | England | British | 111421900001 | |||||||||
| TUBB, Philip Anthony | Amministratore | 15 Mardleybury Road SG3 6SG Datchworth Hertfordshire | British | 98115740001 | ||||||||||
| WARREN, Roy Francis | Amministratore | Glanville Drive Hinton Blewett BS39 5GF Bristol 4 Avon | England | British | 132967870001 | |||||||||
| WOOD, John Hamer | Amministratore | Smith House, Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Rbs Invoice Finance | United Kingdom | British | 136006840001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distant Planet Productions Limited | 11 lug 2017 | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Royal Bank Leasing Limited | 06 apr 2016 | 24/25 St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Midlothian Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NANNY MCPHEE PRODUCTIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Copyright mortgage and assignment | Creato il 31 mar 2004 Consegnato il 19 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right, title and interest of every kind or nature in copyrights and works protectable by copyright, throughout the universe, in and to the underlying screenplay, written by emma thompson and dated 9 march 2004 and any and all versions and revisions thereof,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 31 mar 2004 Consegnato il 19 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right, title and interest, all rights of any kind and nature, domestic and foreign, in and to any literary property, copyright, trademark, service mark, literary property right, personal right, musical right, dramatic right or other literary material, all worldwide copyrights, rights and interests in copyrights, renewals and extensions of copyrights,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of security assignment and charge | Creato il 31 mar 2004 Consegnato il 08 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Right title and interest in and to the entire copyright and all of the other rights in and to the film. The rights of copyright and other rights in all underlying material acquired or crested by the chargor. All literary property and ancillary rights in the film.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0