PEONY LEASING LIMITED

PEONY LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEONY LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04442275
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEONY LEASING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PEONY LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PEONY LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BELLBUY LIMITED20 mag 200220 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEONY LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per PEONY LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 apr 2020

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 apr 2019

    9 pagineLIQ03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 25 Gresham Street London EC2V 7HN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 31 mag 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 apr 2018

    LRESSP

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew John Kemp il 06 apr 2018

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2017 al 29 giu 2017

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2016 al 30 giu 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Andrew John Kemp come amministratore in data 09 gen 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Lloyds Secretaries Limited come segretario in data 20 dic 2016

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Michelle Antoinette Angela Johnson come segretario in data 20 dic 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Owen Williams come amministratore in data 19 set 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mag 2016

    Stato del capitale al 23 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mag 2015

    Stato del capitale al 21 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gerard Ashley Fox il 06 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Owen Williams il 06 mar 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di PEONY LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02791894
    73512200003
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    EnglandBritish152332230001
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    KEMP, Andrew John
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish222042280001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Segretario
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Segretario
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    181115810001
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AITKEN, Joe
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    British123316840001
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    GLASSCOE, Keith Roderick
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    British126272230001
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish191439050001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JUKES, Anthony Wilfrid
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    Amministratore
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    British50640090001
    LIVINGSTON, Stewart Fraser
    86 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Amministratore
    86 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    British111282080002
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Amministratore
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritish94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Amministratore
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Amministratore
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    RICHARDS, Ceri
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    Amministratore
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    British70624480004
    SHARP, Yvonne Easton
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritish126272440001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    SMALLWOOD, James Douglas Mortimer
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish110517930001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomDutch152683120001
    WILLIAMS, Richard Owen
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish164554190001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PEONY LEASING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02279167
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PEONY LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A hong kong ship mortgage
    Creato il 17 mar 2005
    Consegnato il 21 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel named oocl tianjin official number hk-1459.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 21 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A hong kong ship mortgage
    Creato il 28 feb 2005
    Consegnato il 07 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel named oocl atlantic with official number hk-1458.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 07 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known as hull no 1485 and to be named oocl atlanta, registered under the hong kong flag including any share or interest and its engines,machinery,boats,tackle,outfit,etc; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known as hull no 1484 and to be named oocl atlanta,registered under the hong kong flag including any share or interest and its engines,machinery,boats,tackle,outfit,etc; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Hong kong ship mortgage
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 10 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel named oocl long beach registered in the hong kong register of ships with official no. Hk-1017.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A hong kong ship mortgage
    Creato il 29 apr 2003
    Consegnato il 02 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel named oocl shenzhen registered in the hong kong register of ships with official number hk-1015.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K) Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    The deed of covenant
    Creato il 17 apr 2003
    Consegnato il 02 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no.1419 And to be named oocl long beach. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    The deed of covenant
    Creato il 17 apr 2003
    Consegnato il 02 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1418 and to be named oocl shenzhen registered or to registered under the hong kong flag.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Orient Overseas Container Line (U.K) Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    PEONY LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 apr 2018Inizio della liquidazione
    22 gen 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0