PLS GRP LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPLS GRP LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04446608
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PLS GRP LTD?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PLS GRP LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 1 Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Essex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PLS GRP LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    P.L.S GROUP LTD.09 ott 200209 ott 2002
    FREEDOM TECH LTD24 mag 200224 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di PLS GRP LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per PLS GRP LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 044466080007 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter David Mawby Smith il 13 ott 2020

    2 pagineCH01

    Stato del capitale al 28 set 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Modifica dei dettagli di Pls Holdings Limited come persona con controllo significativo il 13 apr 2020

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Peter David Mawby Smith come amministratore in data 01 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Mcmahon come amministratore in data 30 set 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR United Kingdom a Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane Basildon Essex SS14 3BZ in data 09 apr 2019

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 044466080006 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 044466080007, creata il 19 dic 2018

    69 pagineMR01

    Nomina di Mr John William Charles Charlton come amministratore in data 12 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Graham Stuart More come amministratore in data 25 nov 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Jeremy John Cobbett Simpson come amministratore in data 15 ott 2018

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 King George Close Romford Essex RM7 7LS United Kingdom a St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR in data 11 mag 2018

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PLS GRP LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHARLTON, John William Charles
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Segretario
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    230737840001
    CHARLTON, John William Charles
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    EnglandBritish119598150002
    SMITH, Peter David Mawby
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    EnglandBritish159286600004
    FOLEY, Vernon
    10 Upminister Trading Park
    Warley Street
    RM14 3PJ Upminster
    Precision House
    Essex
    Segretario
    10 Upminister Trading Park
    Warley Street
    RM14 3PJ Upminster
    Precision House
    Essex
    Other63884920003
    HOWELL, Simon John
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    203678890001
    MORE, Danielle Lynne
    37 Stewart Avenue
    RM14 2AE Upminster
    Essex
    Segretario
    37 Stewart Avenue
    RM14 2AE Upminster
    Essex
    British27590340002
    CARLTON BAKER CLARKE SECRETARIES LTD
    Suite 1 South House Lodge
    Off Mundon Road
    CM9 6PP Maldon
    Essex
    Segretario
    Suite 1 South House Lodge
    Off Mundon Road
    CM9 6PP Maldon
    Essex
    89540400006
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    M7 4AS Salford
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    M7 4AS Salford
    900014920001
    THE BAKER PARTNERSHIP (UK) SECRETARIES LIMITED
    South House Lodge
    Off Mundon Road
    CM9 6PP Maldon
    Suite 1
    Essex
    England
    Segretario
    South House Lodge
    Off Mundon Road
    CM9 6PP Maldon
    Suite 1
    Essex
    England
    129716590001
    BIRRANE, Sean Thomas
    King George Close
    Romford
    RM7 7LS Essex
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    King George Close
    Romford
    RM7 7LS Essex
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish101296120004
    BLACK, Stuart John
    King George Close
    Romford
    RM7 7LS Essex
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    King George Close
    Romford
    RM7 7LS Essex
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish49053310001
    LOWERY, Steven Robert
    31 Highview Gardens
    RM14 2YU Upminster
    Essex
    Amministratore
    31 Highview Gardens
    RM14 2YU Upminster
    Essex
    United KingdomBritish82281070002
    MCMAHON, Michael
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    Amministratore
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    United KingdomBritish173928090001
    MORE, Graham Stuart
    C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    St James House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor
    St James Square
    GL50 3PR Cheltenham
    St James House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish56850320003
    SIMPSON, Jeremy John Cobbett
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish187009310001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PLS GRP LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    30 giu 2016
    Yardley Business Park
    Luckyn Lane
    SS14 3BZ Basildon
    Unit 1
    Essex
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5690245
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PLS GRP LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2018
    Consegnato il 24 dic 2018
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 24 dic 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 ott 2016
    Consegnato il 21 ott 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 21 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 set 2014
    Consegnato il 10 set 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 giu 2006
    Consegnato il 14 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 10 upminster trading park, warley street, upminster, essex t/n EX569555. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 giu 2006
    Consegnato il 14 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 18 nov 2002
    Consegnato il 20 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as unit 10 upminster trading park,warley st,upminster,essex; ex 569555. with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 nov 2002
    Consegnato il 15 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0