BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED

BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04448005
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELITEDEGREE LIMITED27 mag 200227 mag 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 apr 2016

    18 pagine2.24B

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    19 pagine2.33B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2016

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 ago 2015

    20 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2015

    18 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2015

    18 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2015

    18 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 ago 2014

    21 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2014

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 set 2013

    21 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 apr 2013

    21 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Cessazione della carica di Benjamin Broader come amministratore

    1 pagineTM01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    52 pagine2.17B

    legacy

    53 pagineMG06

    Chi sono gli amministratori di BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ACCOMPLISH SECRETARIES LIMITED
    South Street
    Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    Segretario
    South Street
    Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5752036
    121109170001
    GODDARD, James Michael
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    Segretario
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    British70168860001
    HANSON, Tracey Anna Marie
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    Segretario
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    British64264570001
    MURPHY, Dominic Patrick
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    British82500670001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Segretario
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    British62111350002
    BROADER, Benjamin
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IsraelBritish165999470001
    CLARKE, Jonathan George Gough
    Westland Farm
    Ockley Road
    GU6 7SL Ewhurst
    Surrey
    Amministratore
    Westland Farm
    Ockley Road
    GU6 7SL Ewhurst
    Surrey
    British72712910001
    GILBERT, Paul John Thomas
    Oldfield
    St Mary's Road
    WA14 2PJ Bowden
    Cheshire
    Amministratore
    Oldfield
    St Mary's Road
    WA14 2PJ Bowden
    Cheshire
    EnglandBritish149769990001
    GODDARD, James Michael
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish70168860001
    HANSON, Tracey Anna Marie
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    Amministratore
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    British64264570001
    MACNAUGHTON, Robert Magnus
    High Tong Lodge
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    Kent
    Amministratore
    High Tong Lodge
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    Kent
    British66538980003
    MACRAE, Gregor Charles William
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    Amministratore
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish151235850002
    MURPHY, Dominic Patrick
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish82500670001
    MURRAY, Sean Anthony
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    Amministratore
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish67091270001
    ROBINSON, Philip Thomas
    11 Kennedy Close
    BR5 1HP Orpington
    Kent
    Amministratore
    11 Kennedy Close
    BR5 1HP Orpington
    Kent
    British72559430001
    RUDGE, David
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Amministratore
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish58543980004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    ULTRALINK LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Amministratore
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023330001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Amministratore
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001

    BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental third party security
    Creato il 11 lug 2008
    Consegnato il 17 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Specialised Property Investments Limited (Formerly Rbs Hotel Investments (No.2) Limited)
    Transazioni
    • 17 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 11 lug 2008
    Consegnato il 17 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, senior beneficiaries and stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental debenture
    Creato il 11 lug 2008
    Consegnato il 17 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, senior beneficiaries and stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2005
    Consegnato il 16 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries, the mezzanine beneficiaries, the hillstep senior beneficiaries the hillstep stretch senior beneficiaries and the hillstep mezzanine beneficiaries on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    No. 2 aldersgate lh t/no. NGL705135: no. 8 berners st lh t/no. LN192051 and LN191912: no. 12 birmingham horsefair fh t/no. WM427086 please see form for further details of property charged. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 16 mar 2005
    Third party security
    Creato il 17 nov 2003
    Consegnato il 05 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from powerfocal to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property k/a no 2 aldersgate, t/n NGL705135, the l/h property k/a no 8 berners st, t/ns LB192051 and LN191912, the f/h property k/a no 12 birmingham horsefair, t/n WM427086, see schedule attached to form 395 for other properties charged, the interest in the sale agreements, the occupational leases, the licences, the managing agent's agreement, the head leases, the tax deeds and all agreements in which BPL2 has an interest;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Hotel Investments (No.2) Limited (the Beneficiary)
    Transazioni
    • 05 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 nov 2003
    Consegnato il 05 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the senior beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Non-recourse legal charge
    Creato il 17 nov 2003
    Consegnato il 04 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land known as the two storey underground car park beneath part of the north garden cadogan place chelsea london SW1X 9SA and the land below the car park together with the roof the access ramp and the fire escape staircases the ventilation extract and its housing and the smoke extracts above the roof of the car park. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Non-recourse legal charge by trustees
    Creato il 17 nov 2003
    Consegnato il 02 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land known as the two storey underground car park beneath part of the north garden cadogan place chelsea london SW1X 9SA and the land below the car park together with the roof the access ramp and the fire escape staircases the ventilation extract and its housing and the smoke extracts above the roof of the car park. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Hotel Investments (No. 2) Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Lightweight floating charge
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 23 set 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due rom the obligors to the mezzanine beneficiaries and the stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the assets property and undertaking of the chargor both present and future including all its goodwill and uncalled capital for the time being. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 apr 2016Fine dell'amministrazione
    19 ott 2012Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DataTipo
    09 mar 2016Data della petizione
    22 nov 2016Conclusione della liquidazione
    11 apr 2016Inizio della liquidazione
    05 mar 2017Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Neville Barry Kahn
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0