SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04459630 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TRUSHELFCO (NO.2899) LIMITED | 12 giu 2002 | 12 giu 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 29 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2021 | 10 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU in data 27 gen 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 30 dic 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 apr 2018 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Smothers come amministratore in data 31 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 apr 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 mag 2016 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 22 ago 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT in data 07 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESWICK, Lindsay Anne | Segretario | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | 207524400001 | |||||||
SMOTHERS, Richard | Amministratore | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 242658700001 | ||||
JONES, Henry | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592390001 | |||||||
KENDALL, Timothy James | Segretario | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
RUDD, Susan Clare | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445240001 | |||||||
RUDD, Susan Clare | Segretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181022400001 | |||||||
STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
TRUSEC LIMITED | Segretario nominato | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
BELL, Lucy Jane | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 164754670001 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152083750001 | ||||
DAVIES, Hywel Lloyd | Amministratore | 39 Calvert Road Greenwich SE10 0DH London | British | Solicitor | 89442840001 | |||||
DAVIS, Kathryn Ruth | Amministratore | 16 Elgin Mews South Maida Vale W9 1JZ London | United Kingdom | British | Solicitor | 47610080003 | ||||
DAVIS, Kirk Dyson | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 158484730001 | ||||
DUTTON, Philip | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
GALLAGHER, Patrick James | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | Director | 205366190001 | ||||
GODWIN-BRATT, Robert James | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 170184800001 | ||||
JONES, Karen Elisabeth Dind | Amministratore | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | Director | 47793260007 | ||||
KELLY, Daryl Antony | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 86246470001 | ||||
LANGFORD, Jonathan Robert | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 135408140001 | ||||
MARGERRISON, Russell John | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | Director | 170590800001 | ||||
MCDONALD, Robert James | Amministratore | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
PRESTON, Neil David | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
RIKLIN, Cornel Carl | Amministratore | 103 Barrow Gate Road Chiswick W4 4QS London | England | Swiss | Managing Director | 78412270001 | ||||
SHEPHERD, Andrew | Amministratore | 14 Royal Circus EH3 6SR Edinburgh Lothian | British | Finance Director | 84217490001 | |||||
SMITH, Benedict James | Amministratore | Flat 9 62 Eccleston Square SW1V 1PH London | United Kingdom | British | Director | 75231110001 | ||||
STOKER, Louise Jane | Amministratore | 2nd Floor Flat 45 Hillfield Road, West Hampstead NW6 1QD London | British | Solicitor | 96079800001 | |||||
STONE, Stephen John | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131652460001 | ||||
THORLEY, Giles Alexander | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 81928120002 | ||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Amministratore | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | England | British | Company Director | 135181230001 | ||||
ZUERCHER, Eleanor Jane | Amministratore delegato nominato | 14 St Mary's Court Tingewick MK18 4RE Buckingham Bucks | British | 900019290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Group Equity Limited | 06 apr 2016 | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creato il 31 ott 2003 Consegnato il 12 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 28 feb 2003 Consegnato il 19 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
SPIRIT ACQUISITION PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0