EVER 1824 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEVER 1824 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04460079
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EVER 1824 LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova EVER 1824 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EVER 1824 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per EVER 1824 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 mar 2017

    8 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor Clarence House Clarence Street Manchester M2 4DW a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 14 apr 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 mar 2016

    LRESSP

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2015

    Stato del capitale al 16 giu 2015

    • Capitale: GBP 4
    SH01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    DISS40

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    14 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 giu 2014

    Stato del capitale al 27 giu 2014

    • Capitale: GBP 4
    SH01

    Cessazione della carica di Simon Bate come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Pinnacle 5Th Floor 73 - 79 King Street Manchester M2 4NG England* in data 27 giu 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Kenneth Knott come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Parker come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di David Burkinshaw come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alan Burke come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Old School House George Leigh Street Manchester M4 6AF* in data 08 dic 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di EVER 1824 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROSS, Jonathan Paul
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    Segretario
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    British145992930001
    CROSS, Jonathan Paul
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    Amministratore
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    United KingdomBritish145991240001
    HUGHES, John James
    2 Bamford Road
    M20 2GW Didsbury
    Ivy Bank
    Amministratore
    2 Bamford Road
    M20 2GW Didsbury
    Ivy Bank
    EnglandBritish125765810001
    BATE, Simon Donald
    24 Park Road
    WA15 9NN Altrincham
    Segretario
    24 Park Road
    WA15 9NN Altrincham
    British75874130004
    COUGHLAN, Monica
    Newlands
    Station Road
    SK6 6PA Marple
    Cheshire
    Segretario
    Newlands
    Station Road
    SK6 6PA Marple
    Cheshire
    British106801230001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    ARMSTEAD, Michael Brian
    West House Fiveways
    1 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    West House Fiveways
    1 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish57228500002
    BATE, Simon Donald
    20 East Downs Road
    WA14 2LQ Bowdon
    Paddock House
    Cheshire
    Amministratore
    20 East Downs Road
    WA14 2LQ Bowdon
    Paddock House
    Cheshire
    United KingdomBritish140715780001
    BURKE, Alan Francis
    Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    2
    Cheshire
    Amministratore
    Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    2
    Cheshire
    EnglandBritish182234260001
    BURKINSHAW, David
    Carlton Road
    Urmston
    M41 9GY Manchester
    12
    Amministratore
    Carlton Road
    Urmston
    M41 9GY Manchester
    12
    EnglandBritish149306770001
    DODD, Andrew Gerard
    Court Essington
    Midford
    BA2 7BX Bath
    Amministratore
    Court Essington
    Midford
    BA2 7BX Bath
    United KingdomBritish74768570020
    HENDERSON, Alexander Scott
    The Lilacs
    29 Bower Road Hale
    WA15 9DR Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    The Lilacs
    29 Bower Road Hale
    WA15 9DR Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish115112930001
    KNOTT, Kenneth John
    Etherow Country Park
    Compstall
    SK6 5JQ Stockport
    Foxes Lair
    Cheshire
    Amministratore
    Etherow Country Park
    Compstall
    SK6 5JQ Stockport
    Foxes Lair
    Cheshire
    United KingdomBritish101368570002
    PARKER, Andrew
    Nunnery Way
    Clifford
    LS23 6SL Wetherby
    12
    West Yorkshire
    Amministratore
    Nunnery Way
    Clifford
    LS23 6SL Wetherby
    12
    West Yorkshire
    UkBritish146469710001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Amministratore delegato nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    EVER 1824 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 ott 2009
    Consegnato il 09 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor and each other member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land and buildings at leopold street sheffield and hotel at leopold street sheffield t/nos syk 508127 and syk 508128. l/h 4A leopold square t/n syk 536745. l/h the old school house, george leigh street, manchester and fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The land and buildings k/a the multi screen cinema and public house clippers quay salford l/h t/no GM824520, the land and buildings k/a the land on the west side of trafford road clippers quay salford l/h t/no GM744333, the land and buildings k/a the pump house trafford road salford l/h t/no GM588084. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Bank P.L.C. as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 19 giu 2003
    Consegnato il 02 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land on the south west side og clipper quay trafford road t/n GM474905. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 02 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 feb 2003
    Consegnato il 11 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 2003
    Consegnato il 11 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a multi-screen cinema and public house at clippers quay salford quays t/n gm 824520. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EVER 1824 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 mar 2016Inizio della liquidazione
    31 ago 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0