COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED
Panoramica
Nome della società | COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04461486 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?
- Concessione di credito da parte di istituti finanziari non depositari e altri concedenti specializzati di credito al consumo (64921) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 35 Newhall Street B3 3PU Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CHELTRADING 335 LIMITED | 14 giu 2002 | 14 giu 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 nov 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 17 pagine | LIQ14 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Jessop House Jessop Avenue Cheltenham Glos GL50 3WG a 35 Newhall Street Birmingham B3 3PU in data 29 nov 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione delle attività | 8 pagine | LIQ02 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2016 | 25 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2015 | 22 pagine | AA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 14 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 09 mar 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 044614860012 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 044614860011 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Philip Anthony George come amministratore in data 23 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2014 | 22 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anuj Nehra come amministratore in data 30 giu 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 044614860013 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 044614860013, creata il 20 ott 2014 | 32 pagine | MR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THEOBALD, Timothy Paul | Segretario | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | 165594670001 | |||||||
NEPTUNE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos | 84239630002 | |||||||
BARBOUR, John Fraser Stewart | Amministratore | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Operations Director | 160906180001 | ||||
COHEN, Seth | Amministratore | 9320 Excelsior Blvd Hopkins Carval Investors Minnesota 55343 United States | United States | American | None Supplied | 183025920001 | ||||
LAMMIN, Stuart Mark | Amministratore | 25 Great Pulteney Street 3rd Floor W1F 9LT London Carval Investors United Kingdom | England | British | Investment Manager | 135024660001 | ||||
THEOBALD, Timothy Paul | Amministratore | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 164213700002 | ||||
ASPINALL, Nicholas | Segretario | 52 Vineyard Hill Road SW19 7JH London | British | 76339250001 | ||||||
MILLWARD, Keith Roger | Segretario | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | 158219690001 | |||||||
RUSHBROOK, Daniel James | Segretario | Wedon Way Bygrave SG7 5DX Baldock 311 Herts | British | Solicitor | 101042310002 | |||||
RUSHBROOK, Daniel James | Segretario | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | British | 101042310002 | ||||||
SCALES, Eugene Patrick | Segretario | 10 Fisher Court Rhapsody Crescent CM14 5GE Brentwood Essex | Other | 124193970001 | ||||||
ARCHER, Foster | Amministratore | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | United Kingdom | Irish | Director | 68207500001 | ||||
BACON, Nicholas Andrew William | Amministratore | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Non-Executive Director | 159081540001 | ||||
FARAZMAND, Timothy Bahram Neville | Amministratore | Sandhurst Road DA15 7HL Sidcup 19 Kent | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 41057030002 | ||||
FINEGOLD, Martin Alan | Amministratore | Lexicon House 17 Old Court Place W8 4PL London | United Kingdom | American | Chief Executive | 125782340001 | ||||
GEORGE, Philip Anthony | Amministratore | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131304410001 | ||||
GOWER, Paul John | Amministratore | 76 Orpington Road N21 3PH London | England | British | Director | 87915760001 | ||||
JOHNSON, Alec David | Amministratore | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 103446140001 | ||||
JOHNSON, Stephen David | Amministratore | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | England | British | 103446130001 | |||||
MACDONALD-HALL, Caspar | Amministratore | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | England | British | Company Director | 10281830001 | ||||
MCAULIFFE, Nicholas Paul | Amministratore | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | England | British | Director | 120360430001 | ||||
MILLWARD, Keith Roger | Amministratore | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 80388420001 | ||||
NEHRA, Anuj | Amministratore | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 119449420001 | ||||
PARROTT, Marc Richard | Amministratore | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 30126180002 | ||||
RUSHBROOK, Daniel James | Amministratore | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | British | Solicitor | 101042310002 | |||||
SOUILLARD, Yann Shozo | Amministratore | The Promenade GL50 1WG Cheltenham 95 Glos United Kingdom | United Kingdom | French-American | Private Equity Investor | 132254880001 | ||||
SOUILLARD, Yann Shozo | Amministratore | Canonbury Park South N1 2JJ London 8 | United Kingdom | French-American | Private Equity Investor | 132254880001 | ||||
TURNER, Michael Wallace | Amministratore | No 1 Park House West 50 Park Place GL50 2RA Cheltenham | British | Executive | 80355710002 | |||||
STOORNE INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 900002940001 | |||||||
STOORNE SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 900002930001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercial First Group Limited | 06 apr 2016 | Jessop Avenue GL50 3WG Cheltenham Jessop House Glos | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 20 ott 2014 Consegnato il 03 nov 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 24 apr 2014 Consegnato il 02 mag 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 15 nov 2013 Consegnato il 20 nov 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed relating to a debenture dated 13 may 2008 and | Creato il 22 gen 2009 Consegnato il 30 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 2,000,000 ordinary shares of £1.00 in romford funding limited, 2,000,000 ordinary shares of £1.00 in ilford funding limited see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed | Creato il 14 gen 2009 Consegnato il 23 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed charge 2,000,000 ordinary shares of £1.00 each in romford funding limited pursuant to a written resolution see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed | Creato il 14 gen 2009 Consegnato il 23 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the group to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 mag 2008 Consegnato il 16 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 mag 2008 Consegnato il 16 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 17 gen 2008 Consegnato il 28 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Overriding deed of amendment and guarantee | Creato il 23 nov 2007 Consegnato il 06 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Cfml security provided as security. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 ott 2007 Consegnato il 24 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the group to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over shares | Creato il 02 nov 2004 Consegnato il 18 nov 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from ilford funding limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All shares and the derivative assets. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 dic 2002 Consegnato il 02 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0