COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED

COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04461486
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?

    • Concessione di credito da parte di istituti finanziari non depositari e altri concedenti specializzati di credito al consumo (64921) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHELTRADING 335 LIMITED14 giu 200214 giu 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da Jessop House Jessop Avenue Cheltenham Glos GL50 3WG a 35 Newhall Street Birmingham B3 3PU in data 29 nov 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 07 nov 2018

    LRESEX

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 nov 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 nov 2016

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 set 2016

    Stato del capitale al 01 set 2016

    • Capitale: GBP 1,300.0002
    SH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2015

    22 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    14 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share capital 09/03/2016
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 mar 2016

    • Capitale: GBP 1,300.0002
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 044614860012 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 044614860011 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 lug 2015

    Stato del capitale al 20 lug 2015

    • Capitale: GBP 13,000,002
    SH01

    Cessazione della carica di Philip Anthony George come amministratore in data 23 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 nov 2014

    22 pagineAA

    Cessazione della carica di Anuj Nehra come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 044614860013 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 044614860013, creata il 20 ott 2014

    32 pagineMR01
    Note
    DataNota
    03 nov 2014Other This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Chi sono gli amministratori di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THEOBALD, Timothy Paul
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Segretario
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    165594670001
    NEPTUNE SECRETARIES LIMITED
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    Segretario
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    84239630002
    BARBOUR, John Fraser Stewart
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director160906180001
    COHEN, Seth
    9320 Excelsior Blvd
    Hopkins
    Carval Investors
    Minnesota 55343
    United States
    Amministratore
    9320 Excelsior Blvd
    Hopkins
    Carval Investors
    Minnesota 55343
    United States
    United StatesAmericanNone Supplied183025920001
    LAMMIN, Stuart Mark
    25 Great Pulteney Street
    3rd Floor
    W1F 9LT London
    Carval Investors
    United Kingdom
    Amministratore
    25 Great Pulteney Street
    3rd Floor
    W1F 9LT London
    Carval Investors
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Manager135024660001
    THEOBALD, Timothy Paul
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant164213700002
    ASPINALL, Nicholas
    52 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    Segretario
    52 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    British76339250001
    MILLWARD, Keith Roger
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Segretario
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    158219690001
    RUSHBROOK, Daniel James
    Wedon Way
    Bygrave
    SG7 5DX Baldock
    311
    Herts
    Segretario
    Wedon Way
    Bygrave
    SG7 5DX Baldock
    311
    Herts
    BritishSolicitor101042310002
    RUSHBROOK, Daniel James
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Segretario
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    British101042310002
    SCALES, Eugene Patrick
    10 Fisher Court
    Rhapsody Crescent
    CM14 5GE Brentwood
    Essex
    Segretario
    10 Fisher Court
    Rhapsody Crescent
    CM14 5GE Brentwood
    Essex
    Other124193970001
    ARCHER, Foster
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector68207500001
    BACON, Nicholas Andrew William
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishNon-Executive Director159081540001
    FARAZMAND, Timothy Bahram Neville
    Sandhurst Road
    DA15 7HL Sidcup
    19
    Kent
    Amministratore
    Sandhurst Road
    DA15 7HL Sidcup
    19
    Kent
    United KingdomBritishVenture Capitalist41057030002
    FINEGOLD, Martin Alan
    Lexicon House
    17 Old Court Place
    W8 4PL London
    Amministratore
    Lexicon House
    17 Old Court Place
    W8 4PL London
    United KingdomAmericanChief Executive125782340001
    GEORGE, Philip Anthony
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131304410001
    GOWER, Paul John
    76 Orpington Road
    N21 3PH London
    Amministratore
    76 Orpington Road
    N21 3PH London
    EnglandBritishDirector87915760001
    JOHNSON, Alec David
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director103446140001
    JOHNSON, Stephen David
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    EnglandBritish103446130001
    MACDONALD-HALL, Caspar
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director10281830001
    MCAULIFFE, Nicholas Paul
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector120360430001
    MILLWARD, Keith Roger
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant80388420001
    NEHRA, Anuj
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector119449420001
    PARROTT, Marc Richard
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector30126180002
    RUSHBROOK, Daniel James
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    BritishSolicitor101042310002
    SOUILLARD, Yann Shozo
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    Amministratore
    The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    95
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomFrench-AmericanPrivate Equity Investor132254880001
    SOUILLARD, Yann Shozo
    Canonbury Park South
    N1 2JJ London
    8
    Amministratore
    Canonbury Park South
    N1 2JJ London
    8
    United KingdomFrench-AmericanPrivate Equity Investor132254880001
    TURNER, Michael Wallace
    No 1 Park House West
    50 Park Place
    GL50 2RA Cheltenham
    Amministratore
    No 1 Park House West
    50 Park Place
    GL50 2RA Cheltenham
    BritishExecutive80355710002
    STOORNE INCORPORATIONS LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002940001
    STOORNE SERVICES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore delegato nominato
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002930001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Commercial First Group Limited
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    06 apr 2016
    Jessop Avenue
    GL50 3WG Cheltenham
    Jessop House
    Glos
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneThe Registar Of Companies In The United Kingdom
    Numero di registrazione04461471
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.

    COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 ott 2014
    Consegnato il 03 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cvic Lux Master S.a R.L.
    • Cvf Lux Master S.a R.L
    • Cvi Cvf Ii Master S.a R.L.
    Transazioni
    • 03 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2014
    Consegnato il 02 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 nov 2013
    Consegnato il 20 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed relating to a debenture dated 13 may 2008 and
    Creato il 22 gen 2009
    Consegnato il 30 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    2,000,000 ordinary shares of £1.00 in romford funding limited, 2,000,000 ordinary shares of £1.00 in ilford funding limited see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skipton Building Society
    Transazioni
    • 30 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge 2,000,000 ordinary shares of £1.00 each in romford funding limited pursuant to a written resolution see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 mag 2008
    Consegnato il 16 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 mag 2008
    Consegnato il 16 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skipton Building Society
    Transazioni
    • 16 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 gen 2008
    Consegnato il 28 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 28 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Overriding deed of amendment and guarantee
    Creato il 23 nov 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Cfml security provided as security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 24 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 02 nov 2004
    Consegnato il 18 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from ilford funding limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares and the derivative assets. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2002
    Consegnato il 02 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 02 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    COMMERCIAL FIRST MORTGAGES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 nov 2018Inizio della liquidazione
    07 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan Watson Graham
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Praticante
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Matthew Ingram
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Praticante
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0